the royal gazette / gazette royale (11/02/16) · 2011-02-09 · the royal gazette fredericton new...
Post on 23-Jul-2020
7 Views
Preview:
TRANSCRIPT
The RoyalGazette
FrederictonNew Brunswick
Gazetteroyale
FrederictonNouveau-Brunswick
Vol. 169 Wednesday, February 16, 2011 / Le mercredi 16 février 2011 159
ISSN 1714-9428
Notice to Readers
The Royal Gazette is officially published on-line.
Except for formatting, documents are published in TheRoyal Gazette as submitted.
Material submitted for publication must be received bythe Royal Gazette Coordinator no later than noon, at least7 working days prior to Wednesday’s publication.However, when there is a public holiday, please contactthe Royal Gazette Coordinator at 453-8372.
ORDERPursuant to Order in Council 2011-8, the Proclamation issuedunder Order in Council 2010-576 is corrected by striking out“Acts of New Brunswick, 2008” where it appears therein, andsubstituting therefor “Acts of New Brunswick, 2010”.
This Order is given under my handand the Great Seal of the Province atFredericton on January 13, 2011.
Marie-Claude Blais, Q.C. Graydon NicholasAttorney General Lieutenant-Governor
Proclamations
Avis aux lecteurs
La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne.
Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dansla Gazette royale tels que soumis.
Les documents à publier doivent parvenir à la coordonna-trice de la Gazette royale, à midi, au moins 7 jours ou-vrables avant le mercredi de publication. En cas de jourférié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de laGazette royale au 453-8372.
ORDONNANCEConformément au décret en conseil 2011-8, la proclamationlancée en vertu du décret en conseil 2010-576 est corrigée parla suppression de « Lois du Nouveau-Brunswick de 2008 » àl’endroit où il est mentionné dans ladite proclamation et sonremplacement par « Lois du Nouveau-Brunswick de 2010 ».
La présente ordonnance est renduesous mon seing et le grand sceau dela province, à Fredericton, le13 janvier 2011.
La procureure générale, Le lieutenant-gouverneur,Marie-Claude Blais, c.r. Graydon Nicholas
Proclamations
The Royal Gazette — February 16, 2011 160 Gazette royale — 16 février 2011
JANUARY 13, 20112011-7
Under section 3 of the Civil Service Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints Jean-Marc Dupuis as DeputyMinister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries, effectiveJanuary 24, 2011.
Graydon Nicholas, Lieutenant-Governor
________________
JANUARY 20, 20112011-9
1. Under subsection 8(1) of the Conflict of Interest Act, theLieutenant-Governor in Council designates The HonourableJean-Paul Ouellette as the judge to whom disclosures are to bemade under the Act, effective January 20, 2011.
2. Under subsection 8(1) of the Conflict of Interest Act and sec-tion 21 of the Interpretation Act, the Lieutenant-Governor inCouncil revokes Order in Council 99-319 dated May 6, 1999,effective January 20, 2011.
Graydon Nicholas, Lieutenant-Governor
Orders in Council
ElectionsNew Brunswick
LE 13 JANVIER 20112011-7
En vertu de l’article 3 de la Loi sur la Fonction publique, lelieutenant-gouverneur en conseil nomme Jean-Marc Dupuissous-ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches,à compter du 24 janvier 2011.
Le lieutenant-gouverneur, Graydon Nicholas
________________
LE 20 JANVIER 20112011-9
1. En vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les conflitsd’intérêts, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le jugeJean-Paul Ouellette à titre de juge à qui il faut divulguer toutel’information pertinente en application de la Loi, à compter du20 janvier 2011.2. En vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les conflits d’inté-rêts et de l’article 21 de la Loi d’interprétation, le lieutenant-gouverneur en conseil révoque le décret en conseil 99-319 prisle 6 mai 1999, à compter du 20 janvier 2011.
Le lieutenant-gouverneur, Graydon Nicholas
Décrets en conseil
ÉlectionsNouveau-Brunswick
Pursuant to section 149 of the Elections Act, chapter E-3, Province of New Brunswick, the following changes to the original registra-tions have been entered in the Registry of Political Parties between September 1st, 2010 and December 31st, 2010: / Conformément àl’article 149 de la Loi électorale, chapitre E-3, province du Nouveau-Brunswick, les changements suivants aux enregistrements orig-inaux ont été inscrits au registre des partis politiques entre le 1er septembre 2010 et le 31 décembre 2010 :
LIBERAL PARTY / PARTI LIBÉRAL
Interim Leader / Chef par intérim Victor Boudreau328, rue Main Street, Suite HShediac, NB E4P 2E3
Vice-President Federal / Vice-président fédéral Clifford Lavigne125, chemin Lewisville Road, app./Apt. 207Moncton, NB E1A 8X4
01 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF CAMPBELLTON-RESTIGOUCHE CENTRE (District No. 01) / ASSOCI-ATION DU PARTI LIBÉRAL DE CAMPBELLTON-RESTIGOUCHE-CENTRE (Circonscription no 01)
Official Representative / Représentante officielle Claudette Redstone18, rue John StreetCampbellton, NB E3N 3L9
The Royal Gazette — February 16, 2011 161 Gazette royale — 16 février 2011
04 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF BATHURST (District No. 04) / ASSOCIATION DU PARTI LIBÉRAL DEBATHURST (Circonscription no 04)
President / Présidente Jennifer Cleversey1210, promenade Youghall DriveBathurst, NB E2A 4Y3
05 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF NEPISIGUIT (District No. 05) / ASSOCIATION DU PARTI LIBÉRAL DENEPISIGUIT (Circonscription no 05)
Treasurer / Trésorière Evelyn Daigle576, cour Stout CourtBathurst, NB E2A 2P3
07 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF LAMÈQUE-SHIPPAGAN-MISCOU (District No. 07) / ASSOCIATION DUPARTI LIBÉRAL DE LAMÈQUE-SHIPPAGAN-MISCOU (Circonscription no 07)
President / Président Alonzo Rail203, 2e rue / StreetShippagan, NB E8S 1T4
Treasurer / Trésorier Roger Lanteigne107 B, rue Audet StreetShippagan, NB E8S 1V3
08 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF CENTRE-PÉNINSULE-SAINT-SAUVEUR (District No. 08) / ASSOCIA-TION DU PARTI LIBÉRAL DE CENTRE-PÉNINSULE-SAINT-SAUVEUR (Circonscription no 08)
Treasurer / Trésorier Danny Comeau1906 Route 160Saint-Sauveur, NB E8L 1N4
09 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF TRACADIE-SHEILA (District No. 09) / ASSOCIATION DU PARTILIBÉRAL DE TRACADIE-SHEILA (Circonscription no 09)
President / Président Roland Basque18, rue Freddie StreetSaint-Irénée, NB E1X 2B5
Treasurer / Trésorier Roger St-Pierre655, chemin Alderwood RoadAlderwood, NB E1X 2L2
Registrar / Greffier Armand Doiron786 Route 370Pont-Lafrance, NB E1X 4P2
Official Representative / Représentant officiel Roger St-Pierre655, chemin Alderwood RoadAlderwood, NB E1X 2L2
11 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF MIRAMICHI-BAY DU VIN (District No. 11) / ASSOCIATION DU PARTILIBÉRAL DE MIRAMICHI-BAIE-DU-VIN (Circonscription no 11)
English Vice-President / Vice-présidente anglophone Lillian Williston13, promenade Riverside DriveMiramichi, NB E1N 2Y5
The Royal Gazette — February 16, 2011 162 Gazette royale — 16 février 2011
French Secretary / Secrétaire francophone Adrienne Martin5797 Route 117Baie-Sainte-Anne, NB E9A 1J5
16 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF KENT SOUTH (District No. 16) / ASSOCIATION DU PARTI LIBÉRAL DEKENT-SUD (Circonscription no 16)
Secretary / Secrétaire Jean Cormier117, chemin W. Landry RoadCocagne, NB E4R 3M8
Treasurer / Trésorière Diane Gallant1710, chemin Shediac River RoadShediac River, NB E4R 1X4
Women’s Representative / Colleen McFaddenReprésentante des femmes 5289 Route 535
Dixon Point, NB E4S 3Z7
Official Representative / Représentante officielle Diane Gallant1710, chemin Shediac River RoadShediac River, NB E4R 1X4
17 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF SHEDIAC-CAP-PELÉ (District No. 17) / ASSOCIATION DU PARTILIBÉRAL DE SHEDIAC-CAP-PELÉ (Circonscription no 17)
Treasurer / Trésorière Aurela Landry2407, chemin Acadie RoadCap-Pelé, NB E4N 1B3
21 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF MONCTON EAST (District No. 21) / ASSOCIATION DU PARTI LIBÉRALDE MONCTON-EST (Circonscription no 21)
President / Président Jean-Paul Gallant64, croissant Elsie CrescentMoncton, NB E1A 7W2
Treasurer / Trésorier Jean-Paul Gallant64, croissant Elsie CrescentMoncton, NB E1A 7W2
22 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF MONCTON WEST (District No. 22) / ASSOCIATION DU PARTILIBÉRAL DE MONCTON-OUEST (Circonscription no 22)
Treasurer / Trésorier Robert Dysart189, avenue Broadview AvenueMoncton, NB E1E 1Y4
23 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF MONCTON NORTH (District No. 23) / ASSOCIATION DU PARTILIBÉRAL DE MONCTON-NORD (Circonscription no 23)
Acting President / Président par intérim Jean-Guy Richard90, chemin Heritage RoadNotre-Dame, NB E4V 1Z1
1st Vice-President / 1er(re) Vice-président(e) Vacant
The Royal Gazette — February 16, 2011 163 Gazette royale — 16 février 2011
24 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF MONCTON CRESCENT (District No. 24) / ASSOCIATION DU PARTILIBÉRAL DE MONCTON-CRESCENT (Circonscription no 24)
1st Vice-President / 1er Vice-président Ray Goudreau79, rue Grand Trunk StreetMoncton, NB E1E 0E1
25 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF PETITCODIAC (District No. 25) / ASSOCIATION DU PARTI LIBÉRALDE PETITCODIAC (Circonscription no 25)
Acting President / Présidente par intérim Wendy Ogilvie63, promenade Dundee DriveSalisbury, NB E4J 2B9
1st Vice-President / 1er(re) Vice-président(e) Vacant
27 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF ALBERT (District No. 27) / ASSOCIATION DU PARTI LIBÉRALD’ALBERT (Circonscription no 27)
President / Président Audbur Bishop4112 Route 114Hopewell Hill, NB E4H 3K2
Treasurer / Trésorier Greg Cudmore11, chemin Beechill RoadWeldon, NB E4H 4N3
30 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF QUISPAMSIS (District No. 30) / ASSOCIATION DU PARTI LIBÉRAL DEQUISPAMSIS (Circonscription no 30)
President / Président David Delaney6, promenade Grant DriveQuispamsis, NB E2E 1B2
Vice-President / Vice-président Mark Hatfield429, chemin Hampton RoadQuispamsis, NB E2E 3W6
Electoral District Agent / Agent de circonscription Jack Blaquier79, promenade Hazelton DriveQuispamsis, NB E2E 3B6
31 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF SAINT JOHN-FUNDY (District No. 31) / ASSOCIATION DU PARTILIBÉRAL DE SAINT JOHN-FUNDY (Circonscription no 31)
President / Président Tim Desmond47, promenade Lakeside DriveSaint John, NB E2N 1L4
1st Vice-President / 1er Vice-président Stuart Gray10, chemin Greenhill RoadSaint John, NB E2N 1J8
33 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF SAINT JOHN EAST (District No. 33) / ASSOCIATION DU PARTILIBÉRAL DE SAINT JOHN EAST (Circonscription no 33)
Treasurer / Trésorière Pauline Cosgrove1002-20, rue Prince Edward StreetSaint John, NB E2L 3S2
The Royal Gazette — February 16, 2011 164 Gazette royale — 16 février 2011
Official Representative / Représentante officielle Pauline Cosgrove1002-20, rue Prince Edward StreetSaint John, NB E2L 3S2
35 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF SAINT JOHN PORTLAND (District No. 35) / ASSOCIATION DU PARTILIBÉRAL DE SAINT JOHN PORTLAND (Circonscription no 35)
President / Présidente Shirley McAlary580, rue Main Street, Hilyard PlaceSaint John, NB E2K 1J5
1st Vice-President / 1er Vice-président Jason Court1375, chemin Sandy Point RoadSaint John, NB E2K 5E6
Secretary / Secrétaire Kim Chenier10, terrasse Brigadoon TerraceSaint John, NB E2K 5N5
36 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF SAINT JOHN LANCASTER (District No. 36) / ASSOCIATION DU PARTILIBÉRAL DE SAINT JOHN LANCASTER (Circonscription no 36)
President / Président Neil White105, terrasse Oak TerraceSaint John, NB E2M 4N2
1st Vice-President / 1er Vice-président Mark McAuliffe347, croissant Beaconsfield CrescentSaint John, NB E2M 2H7
2nd Vice-President / 2e Vice-président Bliss White105, terrasse Oak TerraceSaint John, NB E2M 4N2
3rd Vice-President / 3e Vice-présidente Sue Pridham224, avenue Manchester AvenueSaint John, NB E2M 4H3
Secretary / Secrétaire Jeanette Hamm369, chemin Green Head RoadSaint John, NB E2M 4W4
39 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF CHARLOTTE-CAMPOBELLO (District No. 39) / ASSOCIATION DUPARTI LIBÉRAL DE CHARLOTTE-CAMPOBELLO (Circonscription no 39)
President / Présidente Jackie Matthews21, rue Carleton StreetC.p. / P.O. Box 342St. Stephen, NB E3L 2X2
Secretary / Secrétaire Sylvia Humphries407, rue Prince of Wales StreetBoîte / Box 3178Saint Andrews, NB E5B 1R1
The Royal Gazette — February 16, 2011 165 Gazette royale — 16 février 2011
40 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF OROMOCTO (District No. 40) / ASSOCIATION DU PARTI LIBÉRALD’OROMOCTO (Circonscription no 40)
President / Président Joe Carr325, chemin Broad RoadHaneytown, NB E2V 3P4
1st Vice-President / 1re Vice-présidente Loretta Washburn402, rue Covert StreetOromocto, NB E2V 1E7
Secretary / Secrétaire Carol Lindsay20, promenade Bonnar DriveBurton, NB E2V 3J1
Treasurer / Trésorier Sheridan Mawhinney46, croissant Watling CrescentOromocto, NB E2V 4M8
41 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF GRAND LAKE-GAGETOWN (District No. 41) / ASSOCIATION DUPARTI LIBÉRAL DE GRAND LAKE-GAGETOWN (Circonscription no 41)
Official Representative / Représentante officielle Carol McLean122, chemin McLean RoadCumberland Bay, NB E4A 3K3
42 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF FREDERICTON-NASHWAAKSIS (District No. 42) / ASSOCIATION DUPARTI LIBÉRAL DE FREDERICTON-NASHWAAKSIS (Circonscription no 42)
President / Président Léo-Paul Léger153, rue Gill StreetFredericton, NB E3A 3A7
1st Vice-President / 1er Vice-président Bruce Grandy19, promenade Sierra DriveFredericton, NB E3A 5K3
2nd Vice-President / 2e Vice-président(e) Vacant
Treasurer / Trésorière Stacey Agar438, avenue Douglas AvenueFredericton, NB E3A 5T1
43 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF FREDERICTON-FORT NASHWAAK (District No. 43) / ASSOCIATIONDU PARTI LIBÉRAL DE FREDERICTON-FORT NASHWAAK (Circonscription no 43)
1st Vice-President / 1er(re) Vice-président(e) Vacant
46 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF NEW MARYLAND-SUNBURY WEST (District No. 46) / ASSOCIATIONDU PARTI LIBÉRAL DE NEW MARYLAND-SUNBURY-OUEST (Circonscription no 46)
Treasurer / Trésorière Debbie McCann360, chemin Mill Settlement RoadHoyt, NB E5L 2H1
Electoral District Agent / Agente de circonscription Debbie McCann360, chemin Mill Settlement RoadHoyt, NB E5L 2H1
The Royal Gazette — February 16, 2011 166 Gazette royale — 16 février 2011
47 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF YORK (District No. 47) / ASSOCIATION DU PARTI LIBÉRAL D’YORK(Circonscription no 47)
Acting President / Président par intérim Jack WilkinC.p./P.O. Box 315Harvey Station, NB E6K 3W9
48 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF YORK NORTH (District No. 48) / ASSOCIATION DU PARTI LIBÉRALD’YORK-NORD (Circonscription no 48)
Treasurer / Trésorière Susan Gorham332 Route 8Nashwaak Village, NB E6C 1M6
49 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF WOODSTOCK (District No. 49) / ASSOCIATION DU PARTI LIBÉRAL DEWOODSTOCK(Circonscription no 49)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Whitney McGuire148 Route 560Upper Woodstock, NB E7M 3E5
51 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF VICTORIA-TOBIQUE (District No. 51) / ASSOCIATION DU PARTILIBÉRAL DE VICTORIA-TOBIQUE (Circonscription no 51)
Acting President / Présidente par intérim Heather Jensen642 Route 380New Denmark, NB E7G 2Y7
2nd Vice-President / 2e Vice-président(e) Vacant
53 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF RESTIGOUCHE-LA-VALLÉE (District No. 53) / ASSOCIATION DUPARTI LIBÉRAL DE RESTIGOUCHE-LA-VALLÉE (Circonscription no 53)
Official Representative / Représentant officiel Robert Talbot7954 Route 17Kedgwick, NB E8B 1X1
54 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF EDMUNDSTON-SAINT-BASILE (District No. 54) / ASSOCIATION DUPARTI LIBÉRAL D’EDMUNDSTON-SAINT-BASILE (Circonscription no 54)
Acting President / Président par intérim Paul-Émile Soucy711, rue Principale StreetSaint-Basile, NB E7C 1K9
Treasurer / Trésorier Roland Beaulieu44, avenue 23ième AvenueEdmundston, NB E3V 2G7
08 PROGRESSIVE CONSERVATIVE ASSOCIATION OF CENTRE-PÉNINSULE-SAINT-SAUVEUR (DistrictNo. 08) / ASSOCIATION PROGRESSISTE-CONSERVATRICE DE CENTRE-PÉNINSULE-SAINT-SAUVEUR(Circonscription no 08)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Marie-Anne McGraw11427 Route 11Pokemouche, NB E8P 1J2
The Royal Gazette — February 16, 2011 167 Gazette royale — 16 février 2011
09 PROGRESSIVE CONSERVATIVE ASSOCIATION OF TRACADIE-SHEILA (District No. 09) / ASSOCIATIONPROGRESSISTE-CONSERVATRICE DE TRACADIE-SHEILA (Circonscription no 09)
Official Representative / Représentant officiel Jean-Pierre Savoie3818, rue Robinson StreetSaumarez, NB E1X 2K6
Electoral District Agent / Agent de circonscription Jean-Pierre Savoie3818, rue Robinson StreetSaumarez, NB E1X 2K6
15 PROGRESSIVE CONSERVATIVE ASSOCIATION OF KENT (District No. 15) / ASSOCIATION PROGRESSISTE-CONSERVATRICE DE KENT (Circonscription no 15)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Charles Dunn3219 Route 465Beersville, NB E4T 2P1
22 PROGRESSIVE CONSERVATIVE ASSOCIATION OF MONCTON WEST (District No. 22) / ASSOCIATIONPROGRESSISTE-CONSERVATRICE DE MONCTON-OUEST (Circonscription no 22)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Merrill Henderson52, avenue Laird AvenueMoncton, NB E1E 3Y4
42 PROGRESSIVE CONSERVATIVE ASSOCIATION OF FREDERICTON-NASHWAAKSIS (District No. 42) / AS-SOCIATION PROGRESSISTE-CONSERVATRICE DE FREDERICTON-NASHWAAKSIS (Circonscription no 42)
Official Agent / Agent officiel Bruce Currie19, croissant Lilac CrescentFredericton, NB E3A 2G7
46 PROGRESSIVE CONSERVATIVE ASSOCIATION OF NEW MARYLAND-SUNBURY WEST (District No. 46) /ASSOCIATION PROGRESSISTE-CONSERVATRICE DE NEW MARYLAND-SUNBURY-OUEST (Circonscrip-tion no 46)
Official Representative / Représentante officielle Maxine Rideout25, avenue Howe AvenueBeaverdam, NB E3B 8A4
Electoral District Agent / Agente de circonscription Maxine Rideout25, avenue Howe AvenueBeaverdam, NB E3B 8A4
NEW DEMOCRATIC PARTY / NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE
Interim Leader / Chef par intérim Jesse Travis301, chemin Sunpoke RoadRusagonis, NB E3B 8X9
01 CAMPBELLTON-RESTIGOUCHE CENTRE NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (DistrictNo. 01) / ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE CHARLOTTE-CAMPOBELLO (Circonscription no 01)
Electoral District Agent / Agent de circonscription René Parent4-90, rue Dover StreetCampbellton, NB E3N 1P8
The Royal Gazette — February 16, 2011 168 Gazette royale — 16 février 2011
02 DALHOUSIE-RESTIGOUCHE EAST NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 02)/ ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE DALHOUSIE-RESTIGOUCHE-EST (Circonscription no 02)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Adrienne Fradet23210 Route 134Nash Creek, NB E8G 1C4
03 NIGADOO-CHALEUR NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 03) / ASSOCIA-TION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE NIGADOO-CHALEUR (Circon-scription no 03)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Danièle Campagna1-681, rue de la Mer StreetPetit-Rocher, NB E8J 1E4
05 NEPISIGUIT NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 05) / ASSOCIATION DECIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE NEPISIGUIT (Circonscription no 05)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Karen McCrea4554 Route 180South Tetagouche, NB E2A 7G8
06 CARAQUET NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 06) / ASSOCIATION DECIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE CARAQUET (Circonscription no 06)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Stephen Beam2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9
07 LAMÈQUE-SHIPPAGAN-MISCOU NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 07) /ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE LAMÈQUE-SHIPPAGAN-MISCOU (Circonscription no 07)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Calixte Chiasson193, rue du Pêcheur StreetLamèque, NB E8T 1K8
08 CENTRE-PÉNINSULE-SAINT-SAUVEUR NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (DistrictNo. 08) / ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE CENTRE-PÉNINSULE-SAINT-SAUVEUR (Circonscription no 08)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Yvette Robichaud8753-A Route 150Losier Settlement, NB E1X 3B6
10 MIRAMICHI BAY-NEGUAC NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 10) / ASSO-CIATION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE BAIE-DE-MIRAMICHI-NEGUAC (Circonscription no 10)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Sonia Hachey1219 Route 450Saint-Wilfred, NB E9G 2S9
The Royal Gazette — February 16, 2011 169 Gazette royale — 16 février 2011
11 MIRAMICHI-BAY DU VIN NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 11) / ASSOCI-ATION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE MIRAMICHI-BAIE-DU-VIN(Circonscription no 11)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Scott Murphy28, avenue Lobban AvenueMiramichi, NB E1N 2W7
12 MIRAMICHI CENTRE NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 12) / ASSOCIA-TION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE MIRAMICHI-CENTRE (Circon-scription no 12)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Stephen Beam2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9
13 SOUTHWEST MIRAMICHI NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 13) / ASSO-CIATION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE MIRAMICHI-SUD-OUEST(Circonscription no 13)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Stephen Beam2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9
14 ROGERSVILLE-KOUCHIBOUGUAC NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 14)/ ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE ROGERSVILLE-KOUCHIBOUGUAC (Circonscription no 14)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Anne Fagan-Wood10432, rue Principale StreetSaint-Louis-de-Kent, NB E4X 1G5
15 KENT NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 15) / ASSOCIATION DE CIRCON-SCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE KENT (Circonscription no 15)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Fabien Peters38, promenade Echo DriveElsipogtog First Nation, NB E4W 2T5
16 KENT SOUTH NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 16) / ASSOCIATION DECIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE KENT-SUD (Circonscription no 16)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Stephen Beam2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9
Electoral District Agent / Agent de circonscription Stephen Beam2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9
17 SHEDIAC-CAP-PELÉ NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 17) / ASSOCIA-TION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE SHEDIAC-CAP-PELÉ (Circon-scription no 17)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Stephen Beam2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9
The Royal Gazette — February 16, 2011 170 Gazette royale — 16 février 2011
20 DIEPPE CENTRE-LEWISVILLE NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 20) /ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE DIEPPE-CENTRE-LEWISVILLE (Circonscription no 20)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Anne Robichaud49, croissant St-Eustache CrescentDieppe, NB E1A 8P7
21 MONCTON EAST NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 21) / ASSOCIATIONDE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE MONCTON-EST (Circonscription no 21)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Stephen Beam2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9
22 MONCTON WEST NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 22) / ASSOCIATIONDE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE MONCTON-OUEST (Circonscriptionno 22)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Levi Bagley521, rue Main StreetMoncton, NB E1C 1C4
23 MONCTON NORTH NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 23) / ASSOCIATIONDE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE MONCTON-NORD (Circonscriptionno 23)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Stephen Beam2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9
24 MONCTON CRESCENT NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 24) / ASSOCIA-TION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE MONCTON-CRESCENT (Circon-scription no 24)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Stephen Beam2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9
25 PETITCODIAC NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 25) / ASSOCIATION DECIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE PETITCODIAC (Circonscription no 25)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Myrna Geldart46676, chemin Homestead RoadSteeves Mountain, NB E1G 4N7
27 ALBERT NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 27) / ASSOCIATION DE CIR-CONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE D’ALBERT (Circonscription no 27)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Stephen Beam2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9
28 KINGS EAST NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 28) / ASSOCIATION DECIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE KINGS-EST (Circonscription no 28)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Stephen Beam253, rue Northumberland Street, Unit(é) DFredericton, NB E3B 3J6
The Royal Gazette — February 16, 2011 171 Gazette royale — 16 février 2011
29 HAMPTON-KINGS NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 29) / ASSOCIATIONDE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE HAMPTON-KINGS (Circonscriptionno 29)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Gina McLeod11, rue Victoria StreetSaint John, NB E2M 1A7
30 QUISPAMSIS NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 30) / ASSOCIATION DECIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE QUISPAMSIS (Circonscription no 30)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Debra Lindsay111, promenade Fox Point DriveSaint John, NB E2H 2Z1
31 SAINT JOHN-FUNDY NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 31) / ASSOCIA-TION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE SAINT JOHN-FUNDY (Circon-scription no 31)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Stephen Beam2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9
32 ROTHESAY NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 32) / ASSOCIATION DECIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE ROTHESAY (Circonscription no 32)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Stephen Beam2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9
33 SAINT JOHN EAST NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 33) / ASSOCIATIONDE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE SAINT JOHN-EST(Circonscriptionno 33)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Patricia Hay400, chemin Sandy Point RoadSaint John, NB E2K 3R9
34 SAINT JOHN HARBOUR NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 34) / ASSOCI-ATION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE SAINT JOHN HARBOUR (Cir-conscription no 34)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Matthew Brown66, rue Tilley StreetHampton, NB E2N 8E3
35 SAINT JOHN PORTLAND NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 35) / ASSOCI-ATION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE SAINT JOHN PORTLAND (Cir-conscription no 35)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Jen Butler11, chemin Grantham RoadSaint John, NB E2K 0B8
The Royal Gazette — February 16, 2011 172 Gazette royale — 16 février 2011
36 SAINT JOHN LANCASTER NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 36) / ASSO-CIATION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE SAINT JOHN LANCASTER(Circonscription no 36)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Khalid Malik1660, chemin Manawagonish RoadSaint John, NB E2M 3Y3
37 FUNDY-RIVER VALLEY NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 37) / ASSOCIA-TION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE FUNDY-RIVER VALLEY (Circon-scription no 37)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Stephen Beam2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9
38 CHARLOTTE-THE ISLES NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 38) / ASSOCI-ATION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE CHARLOTTE-LES-ÎLES (Cir-conscription no 38)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Stephen Beam2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9
39 CHARLOTTE-CAMPOBELLO NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 39) / AS-SOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE CHARLOTTE-LES-ÎLES(Circonscription no 39)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Wendy Tubbs42, chemin Old Bay RoadOak Bay, NB E3L 3W8
40 OROMOCTO NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 40) / ASSOCIATION DECIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE D’OROMOCTO (Circonscription no 40)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Stephen Beam2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9
41 GRAND LAKE-GAGETOWN NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 41) / ASSO-CIATION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE GRAND LAKE-GAGETOWN(Circonscription no 41)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Stephen Beam253, rue Northumberland Street, Unit(é) DFredericton, NB E3B 3J6
42 FREDERICTON-NASHWAAKSIS NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 42) /ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE FREDERICTON-NASHWAAKSIS (Circonscription no 42)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Stephen Beam2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9
The Royal Gazette — February 16, 2011 173 Gazette royale — 16 février 2011
43 FREDERICTON-FORT NASHWAAK NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 43)/ ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE FREDERICTON-FORT NASHWAAK (Circonscription no 43)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Stephen Beam2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9
44 FREDERICTON-LINCOLN NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 44) / ASSO-CIATION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE FREDERICTON-LINCOLN(Circonscription no 44)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Greg Ericson4, allée Wayne LaneFredericton, NB E3B 9S6
45 FREDERICTON-SILVERWOOD NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 45) /ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE FREDERICTON-SILVERWOOD (Circonscription no 45)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Stephen Beam2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9
46 NEW MARYLAND-SUNBURY WEST NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 46)/ ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE NEW MARYLAND-SUNBURY-OUEST (Circonscription no 46)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Jacob Travis301, chemin Sunpoke RoadRusagonis, NB E3B 8X9
51 VICTORIA-TOBIQUE NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 51) / ASSOCIA-TION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE VICTORIA-TOBIQUE (Circon-scription no 51)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Stephen Beam2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9
52 GRAND FALLS-DRUMMOND-SAINT-ANDRÉ NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (Dis-trict No. 52) / ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE GRAND-SAULT-DRUMMOND-SAINT-ANDRÉ (Circonscription no 52)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Stephen Beam2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9
53 RESTIGOUCHE-LA-VALLÉE NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 53) /ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE RESTIGOUCHE-LA-VALLÉE (Circonscription no 53)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Thérèse Paquet5, rue Notre-Dame StreetKedgwick, NB E8B 1H2
The Royal Gazette — February 16, 2011 174 Gazette royale — 16 février 2011
54 EDMUNDSTON-SAINT-BASILE NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 54) / AS-SOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE D’EDMUNDSTON-SAINT-BASILE - (Circonscription no 54)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Stephen Beam2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9
55 MADAWASKA-LES-LACS NEW DEMOCRATIC PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 55) / ASSOCI-ATION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE MADAWASKA-LES-LACS (Cir-conscription no 55)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Stephen Beam2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9
01 CAMPBELLTON-RESTIGOUCHE CENTRE PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION(District No. 01) / ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DECHARLOTTE-CAMPOBELLO (Circonscription no 01)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Carolyn A. O’Rourke106, chemin O’Leary RoadBeaver Dam, NB E3B 7W2
02 DALHOUSIE-RESTIGOUCHE EAST PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (DistrictNo. 02) / ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DE DALHOUSIE-RESTIGOUCHE-EST (Circonscription no 02)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Carolyn A. O’Rourke106, chemin O’Leary RoadBeaver Dam, NB E3B 7W2
03 NIGADOO-CHALEUR PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 03) / ASSO-CIATION DE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DE NIGADOO-CHALEUR (Circon-scription no 03)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Carolyn A. O’Rourke106, chemin O’Leary RoadBeaver Dam, NB E3B 7W2
04 BATHURST PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 04) / ASSOCIATIONDE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DE BATHURST (Circonscription no 04)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Carolyn A. O’Rourke106, chemin O’Leary RoadBeaver Dam, NB E3B 7W2
05 NEPISIGUIT PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 05) / ASSOCIATIONDE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DE NEPISIGUIT (Circonscription no 05)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Carolyn A. O’Rourke106, chemin O’Leary RoadBeaver Dam, NB E3B 7W2
The Royal Gazette — February 16, 2011 175 Gazette royale — 16 février 2011
10 MIRAMICHI BAY-NEGUAC PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 10) /ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DE BAIE-DE-MIRAMICHI-NEGUAC (Circonscription no 10)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Carolyn A. O’Rourke106, chemin O’Leary RoadBeaver Dam, NB E3B 7W2
11 MIRAMICHI-BAY DU VIN PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 11) / AS-SOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DE MIRAMICHI-BAIE-DU-VIN(Circonscription no 11)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Carolyn A. O’Rourke106, chemin O’Leary RoadBeaver Dam, NB E3B 7W2
12 MIRAMICHI CENTRE PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 12) / ASSO-CIATION DE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DE MIRAMICHI-CENTRE (Circon-scription no 12)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Carolyn A. O’Rourke106, chemin O’Leary RoadBeaver Dam, NB E3B 7W2
13 SOUTHWEST MIRAMICHI PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 13) /ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DE MIRAMICHI-SUD-OUEST (Circonscription no 13)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Carolyn A. O’Rourke106, chemin O’Leary RoadBeaver Dam, NB E3B 7W2
15 KENT PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 15) / ASSOCIATION DE CIR-CONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DE KENT (Circonscription no 15)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Carolyn A. O’Rourke106, chemin O’Leary RoadBeaver Dam, NB E3B 7W2
16 KENT SOUTH PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 16) / ASSOCIATIONDE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DE KENT-SUD (Circonscription no 16)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Odette Fournier1656, chemin St-Joseph RoadSainte-Marie-de-Kent, NB E4S 2G9
17 SHEDIAC-CAP-PELÉ PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 17) / ASSO-CIATION DE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DE SHEDIAC-CAP-PELÉ (Circon-scription no 17)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Carolyn A. O’Rourke106, chemin O’Leary RoadBeaver Dam, NB E3B 7W2
The Royal Gazette — February 16, 2011 176 Gazette royale — 16 février 2011
23 MONCTON NORTH PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 23) / ASSOCI-ATION DE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DE MONCTON-NORD (Circonscrip-tion no 23)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Carolyn A. O’Rourke106, chemin O’Leary RoadBeaver Dam, NB E3B 7W2
27 ALBERT PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 27) / ASSOCIATION DECIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY D’ALBERT (Circonscription no 27)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Carolyn A. O’Rourke106, chemin O’Leary RoadBeaver Dam, NB E3B 7W2
28 KINGS EAST PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 28) / ASSOCIATIONDE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DE KINGS-EST (Circonscription no 28)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Carolyn A. O’Rourke106, chemin O’Leary RoadBeaver Dam, NB E3B 7W2
33 SAINT JOHN EAST PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 33) / ASSOCI-ATION DE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DE SAINT JOHN-EST (Circonscriptionno 33)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Carolyn A. O’Rourke106, chemin O’Leary RoadBeaver Dam, NB E3B 7W2
34 SAINT JOHN HARBOUR PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 34) / AS-SOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DE SAINT JOHN HARBOUR(Circonscription no 34)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Carolyn A. O’Rourke106, chemin O’Leary RoadBeaver Dam, NB E3B 7W2
35 SAINT JOHN PORTLAND PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 35) / AS-SOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DE SAINT JOHN PORTLAND(Circonscription no 35)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Carolyn A. O’Rourke106, chemin O’Leary RoadBeaver Dam, NB E3B 7W2
36 SAINT JOHN LANCASTER PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 36) /ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DE SAINT JOHNLANCASTER (Circonscription no 36)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Carolyn A. O’Rourke106, chemin O’Leary RoadBeaver Dam, NB E3B 7W2
The Royal Gazette — February 16, 2011 177 Gazette royale — 16 février 2011
37 FUNDY-RIVER VALLEY PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 37) / AS-SOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DE FUNDY-RIVER VALLEY(Circonscription no 37)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Carolyn A. O’Rourke106, chemin O’Leary RoadBeaver Dam, NB E3B 7W2
38 CHARLOTTE-THE ISLES PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 38) / AS-SOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DE CHARLOTTE-LES-ÎLES(Circonscription no 38)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Carolyn A. O’Rourke106, chemin O’Leary RoadBeaver Dam, NB E3B 7W2
39 CHARLOTTE-CAMPOBELLO PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 39)/ ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DE CHARLOTTE-CAMPOBELLO (Circonscription no 39)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Susan Eddy4725 Route 127Chamcook, NB E5B 2Z4
40 OROMOCTO PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 40) / ASSOCIATIONDE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY D’OROMOCTO (Circonscription no 40)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Carolyn A. O’Rourke106, chemin O’Leary RoadBeaver Dam, NB E3B 7W2
41 GRAND LAKE-GAGETOWN PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 41) /ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DE GRAND LAKE-GAGETOWN (Circonscription no 41)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Carolyn A. O’Rourke106, chemin O’Leary RoadBeaver Dam, NB E3B 7W2
44 FREDERICTON-LINCOLN PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 44) /ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DE FREDERICTON-LINCOLN (Circonscription no 44)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Carolyn A. O’Rourke106, chemin O’Leary RoadBeaver Dam, NB E3B 7W2
47 YORK PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 47) / ASSOCIATION DE CIR-CONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY D’YORK - (Circonscription no 47)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Carolyn A. O’Rourke106, chemin O’Leary RoadBeaver Dam, NB E3B 7W2
The Royal Gazette — February 16, 2011 178 Gazette royale — 16 février 2011
49 WOODSTOCK PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 49) / ASSOCIATIONDE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DE WOODSTOCK (Circonscription no 49)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Carolyn A. O’Rourke106, chemin O’Leary RoadBeaver Dam, NB E3B 7W2
53 RESTIGOUCHE-LA-VALLÉE PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 53) /ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DE RESTIGOUCHE-LA-VALLÉE (Circonscription no 53)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Carolyn A. O’Rourke106, chemin O’Leary RoadBeaver Dam, NB E3B 7W2
54 EDMUNDSTON-SAINT-BASILE PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 54)/ ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY D’EDMUNDSTON-SAINT-BASILE (Circonscription no 54)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Carolyn A. O’Rourke106, chemin O’Leary RoadBeaver Dam, NB E3B 7W2
13 SOUTHWEST MIRAMICHI PEOPLE’S ALLIANCE OF NEW BRUNSWICK (District No. 13) / L’ALLIANCEDES GENS DU NOUVEAU-BRUNSWICK DE MIRAMICHI-SUD-OUEST (Circonscription no 13)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Sarah Gullison6655 Route 8Ludlow, NB E9C 2H7
23 MONCTON NORTH PEOPLE’S ALLIANCE OF NEW BRUNSWICK (District No. 23) / L’ALLIANCE DES GENSDU NOUVEAU-BRUNSWICK DE MONCTON-NORD (Circonscription no 23)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Christine Thompson40, allée Woodmount LaneMinto, NB E4B 3A2
27 ALBERT PEOPLE’S ALLIANCE OF NEW BRUNSWICK (District No. 27) / L’ALLIANCE DES GENS DUNOUVEAU-BRUNSWICK D’ALBERT (Circonscription no 27)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Clara Smith-Collins255, chemin Niagara RoadPine Glen, NB E1J 1J2
31 SAINT JOHN-FUNDY PEOPLE’S ALLIANCE OF NEW BRUNSWICK (District No. 31) / L’ALLIANCE DESGENS DU NOUVEAU-BRUNSWICK DE SAINT JOHN-FUNDY (Circonscription no 31)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Warren Brothers130, place Inverness Place, Suite 10Saint John, NB E2J 3Z8
35 SAINT JOHN PORTLAND PEOPLE’S ALLIANCE OF NEW BRUNSWICK (District No. 35) / L’ALLIANCE DESGENS DU NOUVEAU-BRUNSWICK DE SAINT JOHN PORTLAND (Circonscription no 35)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Erica-Lea White5-105, rue Main StreetSaint John, NB E2K 1H2
The Royal Gazette — February 16, 2011 179 Gazette royale — 16 février 2011
36 SAINT JOHN LANCASTER PEOPLE’S ALLIANCE OF NEW BRUNSWICK (District No. 36) / L’ALLIANCEDES GENS DU NOUVEAU-BRUNSWICK DE SAINT JOHN LANCASTER (Circonscription no 36)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Jennifer Green68, rue Violet StreetSaint John, NB E2M 5M4
37 FUNDY-RIVER VALLEY PEOPLE’S ALLIANCE OF NEW BRUNSWICK (District No. 37) / L’ALLIANCE DESGENS DU NOUVEAU-BRUNSWICK DE FUNDY-RIVER VALLEY (Circonscription no 37)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Tracy L. Mayhew85, chemin School Bus RoadSaint John, NB E2M 7E8
38 CHARLOTTE-THE ISLES PEOPLE’S ALLIANCE OF NEW BRUNSWICK (District No. 38) / L’ALLIANCE DESGENS DU NOUVEAU-BRUNSWICK DE CHARLOTTE-LES-ÎLES (Circonscription no 38)
Electoral District Agent / Agente de circonscription Cindy R. Cook5440 Route 1, Boîte/Box 202Pennfield, NB E5H 2M1
49 WOODSTOCK PEOPLE’S ALLIANCE OF NEW BRUNSWICK (District No. 49) / L’ALLIANCE DES GENS DUNOUVEAU-BRUNSWICK DE WOODSTOCK (Circonscription no 49)
Electoral District Agent / Agent de circonscription Calvin Brennan272, chemin Beardsley RoadWoodstock, NB E7M 4E3
_____________________________________________________
Pursuant to subsection 147(2) of the Elections Act, chapter E-3, Province of New Brunswick, the following district associations andindependent candidates have been registered as provided for in section 135 and 136 of the Elections Act: / Conformément au para-graphe 147(2) de la Loi électorale, chapitre E-3, province du Nouveau-Brunswick, les associations de circonscription et les candidatsindépendants suivants ont été enregistrés comme le prévoient les articles 135 et 136 de la Loi électorale :
17 INDEPENDENT CANDIDATE – SHEDIAC-CAP-PELÉ (District No. 17) / CANDIDAT INDÉPENDANT –SHEDIAC-CAP-PELÉ (Circonscription no 17)
Candidate / Candidat Charles Vautour119, chemin Medor RoadCocagne, NB E4R 2T5
Official Representative / Représentant officiel Bernard LeBlanc1791, rue Amirault StreetDieppe, NB E1A 7J7
Official Agent / Agent officiel Bernard LeBlanc1791, rue Amirault StreetDieppe, NB E1A 7J7
The Royal Gazette — February 16, 2011 180 Gazette royale — 16 février 2011
22 INDEPENDENT CANDIDATE – MONCTON WEST (District No. 22) / CANDIDAT INDÉPENDANT –MONCTON-OUEST (Circonscription no 22)
Candidate / Candidat Barry Renouf307-35, rue Bonaccord StreetMoncton, NB E1C 0M7
Official Representative / Représentant officiel Daryl Doucette71, promenade Briardale DriveMoncton, NB E1G 2B4
Official Agent / Agent officiel Daryl Doucette71, promenade Briardale DriveMoncton, NB E1G 2B4
45 INDEPENDENT CANDIDATE – FREDERICTON-SILVERWOOD (District No. 45) / CANDIDAT INDÉPEN-DANT – FREDERICTON-SILVERWOOD (Circonscription no 45)
Candidate / Candidat Jim Andrews150 Cassidy CircleFredericton, NB E3B 7N3
49 INDEPENDENT CANDIDATE – WOODSTOCK (District No. 49) / CANDIDAT INDÉPENDANT – WOODSTOCK(Circonscription no 49)
Candidate / Candidat Dale E. Allen10-103, rue Searle StreetWoodstock, NB E7M 0C9
Official Representative / Représentante officielle Audrey Gervais103, chemin Lockhart Mill RoadJacksonville, NB E7M 5J9
Official Agent / Agent officiel Andrew Lenehan2-261, rue Connell StreetWoodstock, NB E7M 1L2
55 INDEPENDENT CANDIDATE – MADAWASKA-LES-LACS (District No. 55) / CANDIDAT INDÉPENDANT –MADAWASKA-LES-LACS (Circonscription no 55)
Candidate / Candidat Jean-Marc Nadeau203, chemin de l’Église StreetLac Baker, NB E7A 1N7
Official Representative / Représentante officielle Melissa Nadeau17, rue Patrick StreetSaint-Jacques, NB E7B 2X4
Official Agent / Agente officielle Melissa Nadeau17, rue Patrick StreetSaint-Jacques, NB E7B 2X4
Michael P. QuinnChief Electoral Officer / Directeur général des élections
The Royal Gazette — February 16, 2011 181 Gazette royale — 16 février 2011
654293 N.B. Inc. Miramichi 654293 2011 01 24
Home Genies Cleaning Service Inc. Fredericton 655262 2011 01 13
Wavetec Marine Ltd. Rothesay 655277 2011 01 13
J. K. E. Quality Homes Inc. Coles Island 655388 2011 01 19
Wall Street Equities Ltd. Shediac 655411 2011 01 20
DR. DETAIL ATLANTIC INC. Moncton 655416 2011 01 20
Five Star Specialized Carriers Inc. Quispamsis 655422 2011 01 21
BENI HOLDINGS INC. Moncton 655423 2011 01 21
Mont3043 Fredericton Inc. Moncton 655424 2011 01 21
Mont3095 Saint John Inc. Moncton 655425 2011 01 21
Mont3630 Moncton Inc. Moncton 655426 2011 01 21
655427 N.B. Inc. Moncton 655427 2011 01 21
BIG T TRUCKING LTD. Geary 655428 2011 01 21
655429 N.B. INC. Quispamsis 655429 2011 01 21
655437 NB Ltd. Riverview 655437 2011 01 21
655438 NB Ltd. Riverview 655438 2011 01 21
Worthie World Energy Inc. / Worthie Monde Énergie Inc. Saint-Quentin 655439 2011 01 21
655440 N.B. Ltd. Moncton 655440 2011 01 21
655441 N.B. Ltd. Moncton 655441 2011 01 21
655442 N.B. Ltd. Moncton 655442 2011 01 21
The Candy Cottage Inc. Miramichi 655444 2011 01 23
CARBON TRANSIT INC. Hartland 655449 2011 01 24
KD Saunders Construction Ltd. Quispamsis 655451 2011 01 24
655453 N.B. Ltd. Saint John 655453 2011 01 24
George Street Property Services Inc. Fredericton 655454 2011 01 24
Comeau Capital Corporation Bathurst 655455 2011 01 24
McLaughlin Brothers Farming Operations Ltd. Saint John 655456 2011 01 24
DRE RACHELLE B. SAVOIE C.P. INC. Bathurst 655457 2011 01 24
Loi sur les corporations commercialesBusiness Corporations Act
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of incorporation has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commercia-les, un certificat de constitution en corporation a été émis à :
ReferenceNumber Date
Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour
The Royal Gazette — February 16, 2011 182 Gazette royale — 16 février 2011
655458 N.B. Inc. Fredericton 655458 2011 01 24
Smarter Business Barter Network Inc. Second North River 655460 2011 01 24
I & C Thorough Cleaners Incorporated Saint John 655465 2011 01 25
655471 NB INC. Bathurst 655471 2011 01 25
Absolute Childcare Inc. Shediac 655472 2011 01 25
PJ ATLANTIC RESTAURANTS (SUSSEX) LTD. Lower Coverdale 655473 2011 01 25
ST-LOUIS VILLAGE CAFÉ INC. Saint-Louis 655474 2011 01 25
TAD Investments Inc. Waterville 655476 2011 01 25Comté de Carleton County
Aura Ventures Corp. Shediac 655477 2011 01 25
IND FORESTRY INC. Rusagonis 655478 2011 01 25
CANADA WIDE MILLWORK INC. Keswick Ridge 655479 2011 01 25
Koze Corner Special Care Home Inc. Temperance Vale 655480 2011 01 25
ProTrans Canada, Inc. Saint John 655481 2011 01 25
GRD ROAD SERVICE CO. LTD. Wicklow 655482 2011 01 25
R N R Leasing Ltd. Moncton 655485 2011 01 25
Carrolls Crossing Grilse & Grouse Inc. Fredericton 655488 2011 01 25
Dream Street TGL Pictures Inc. Fredericton 655490 2011 01 25
J.-P. LEVESQUE HOLDINGS INC. Charlo 655493 2011 01 25
A. LEVESQUE HOLDINGS INC. Charlo 655494 2011 01 25
YALWA INC. Saint John 655495 2011 01 26
Netbuyz Advertising Inc. Fredericton 655497 2011 01 26
Tantastic Summer Tanning Salon Ltd Petitcodiac 655498 2011 01 26
Dayzee’s Fashions Ltd. Moncton 655499 2011 01 26
National Medical Equipment Inc. Moncton 655501 2011 01 26
655502 NB LTD./ 655502 NB LTEE Dieppe 655502 2011 01 26
655503 N.B. Ltd. Riverview 655503 2011 01 26
Oriental Pearl Restaurant Ltd. Fredericton 655504 2011 01 26
DIRECT ROUTE CARRIERS LTD. McLaughlin 655505 2011 01 26
Boundary Creek Paving Inc. Boundary Creek 655506 2011 01 26
DARI DELITE TASTY FLAVORS INC Grand-Sault / Grand Falls 655507 2011 01 26
Holland Home Holdings Inc. Saint John 655511 2011 01 26
IES Individual Employment Solutions Inc. Moncton 655512 2011 01 26
AJR Technical & Quality Services Ltd. Miramichi 655514 2011 01 26
D & L Family Fun Pools Inc. Rough Waters 655519 2011 01 26
655520 NB LTD. Bathurst 655520 2011 01 26
The Royal Gazette — February 16, 2011 183 Gazette royale — 16 février 2011
KA Farms Inc. Upper Knoxford 655522 2011 01 27
655532 N.B. Ltd. Killarney Road 655532 2011 01 27
Mikumi Explorations Corp. Shediac 655534 2011 01 27
GESTION EMAF INC. Tracadie-Sheila 655536 2011 01 27
GESTION JULIEN BREAU INC. Saint-Isidore 655542 2011 01 27
SPRAY TECHNOLOGY LTD. Lower Greenwich 655543 2011 01 27
MCW Energy Group Limited Shediac 655545 2011 01 27
N & D Mac Holdings Ltd. Fredericton 655546 2011 01 28
OHL-FCC GP Canada Inc. Saint John 655553 2011 01 28
655554 NB Inc. Saint John 655554 2011 01 28
Integrated Meaning Systems Ltd. Bayswater 655563 2011 01 28
_____________________________________________________
PROSSER ENTERPRISES LTD. 013442 2011 01 25
RUSCO SAINT JOHN LIMITED 035009 2011 01 26
GRAND MANAN HARDWARE LTD. 039892 2011 01 26
CLASSIC CONSTRUCTION LTD. 040463 2011 01 27
MASTER MECHANICAL CONTRACTORS INC. 059748 2011 01 24
NORMAC PHARMACY LTD. 508176 2011 01 28
AQUILA TOURS INC. 508519 2011 01 27
General Dynamics Land Systems - Canada International Services Inc. 628195 2011 01 25
Springhill Management Limited 640858 2011 01 28
André Paulin Corporation Professionnelle Inc. 642389 2011 01 26
D. BREAU & FILS LTEE 643859 2011 01 27
Cedar Cliff Holdings Ltd. 649169 2011 01 28
649411 NB Inc. 649411 2011 01 27
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification a été émis à :
DateReference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour
The Royal Gazette — February 16, 2011 184 Gazette royale — 16 février 2011
Gaddess Industrial Inc. MINTO MACHINE & WELDING LTD. 011030 2011 01 25
Martin Mazda Ltée G.P. MARTIN AUTO LTEE. 035583 2011 01 28
POAC Canada, Inc. AP Specialty Metals Canada, Inc. 513130 2011 01 24
Les Entreprises Bisons L.T. Inc. VIDEO L.T. (2007) INCORPORÉE 630213 2010 12 10
Alan Mockler Capital Corporation Alan Mockler Ventures Ltd. 649219 2011 01 27
Elizabethtown Solar Park 1 GP Inc. Cobden Solar Park 1 GP Inc. 654025 2011 01 26
Wooler Solar Park 1 GP Inc. Cobden Solar Park 2 GP Inc. 654026 2011 01 26
_____________________________________________________
NORDIC CONSULTANTS LTEE Edmundston 012243 2011 01 20
ATLANTIC TOTAL COMMUNICATIONS INC. Moncton 506769 2011 01 20
509003 N. B. Ltd. Apohaqui 509003 2011 01 26
605818 N.B. Ltd. Moncton 605818 2011 01 20
HEAVY DUTY RECYCLING INC. Bathurst 612785 2011 01 20
634483 N.B. Ltd. Blacks Harbour 634483 2011 01 24
GJG CONSULTING INC. Kingston 638293 2011 01 20
HEAL THY SELF INC. Woodstock 639794 2011 01 21
TORO HARD SURFACE SOLUTIONS LTD. Somerville 645701 2011 01 27
Mirror Images Salon Ltd. Fredericton 651997 2011 01 27
_____________________________________________________
TORO FOUNDATIONS INC. 629770 2011 01 24
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment which includes a change inname has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification contenant un changement de raisonsociale a été émis à :
DatePrevious name Reference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of dissolution has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de dissolution a été émis à :
ReferenceNumber Date
Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a restated certificate of incorporation has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de constitution mise à jour a été émis à :
DateReference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour
The Royal Gazette — February 16, 2011 185 Gazette royale — 16 février 2011
J.W.G. HOLDINGS LTD. Nouvelle-Écosse / Nova Scotia 008693 2011 01 13
ULTRA ALARM SERVICES (2002) LTD. Ontario 604128 2010 12 29
City Bakery (Calgary) Ltd. Ontario 604350 2010 12 23
Seroyal International Inc. Canada 632819 2011 01 19
_____________________________________________________
HARRIGAN INSURANCE AGENCY LTD. 007806 2011 01 24
LES RESTAURATIONS DU NORD LTEE.- 013912 2011 01 25NORTHERN RESTAURANTS LTD.
ROBERTSON’S GREENHOUSES LTD. 014176 2011 01 20
HUNTINGTON DEVELOPMENTS LTD. 042860 2011 01 20
055172 N.B. LTD. 055172 2011 01 20
M & B TRAILER MANUFACTURING INC. 510191 2011 01 27
604081 NB Ltd. 604081 2011 01 21
KELLY WREATHS & XMAS TREES INC. 626603 2011 01 20
Doncon Enterprises Inc. 627808 2011 01 20
JCG P.C. Management Inc. 629382 2011 01 20
_____________________________________________________
CIS CANADIAN INSURANCE Ontario SMSS Corporate Services (NB) Inc. 654732 2011 01 26SERVICES CORP. Saint John
Compupro2010 Inc. Canada Steve Pellerin 655139 2011 01 14Edmundston
PROSOL DISTRIBUTION INC. Canada William J. Matthews 655275 2011 01 13Fredericton
Groupama Transport France Rodney J. Gillis 655283 2011 01 14Saint John
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of discontinuance has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de cessation a été émis à :
DateJurisdiction of Continuance Reference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Compétence de prorogation Numéro de référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of revival has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de reconstitution a été émis à :
DateReference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of extra-provincial corporationhas been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a étéémis à :
ReferenceNumber Date
Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour
The Royal Gazette — February 16, 2011 186 Gazette royale — 16 février 2011
Signarama Canada 2010 Ltd. Canada SMSS Corporate Services (NB) Inc. 655285 2011 01 14Saint John
MEIDAN ENTERPRISE INC. Canada Joanne Hadley C.P. Inc. 655297 2011 01 14Dieppe
NBC COMMODITIES (2010) INC. / Canada SMSS Corporate Services (NB) Inc. 655310 2011 01 17NBC MARCHANDISES (2010) INC. Saint John
7743882 Canada Inc. Canada SMSS Corporate Services (NB) Inc. 655314 2011 01 17Saint John
Garrett Agencies Ltd. Alberta R. Bruce Eddy 655337 2011 01 17Fredericton
Simply You Ltd. Ontario SMSS Corporate Services (NB) Inc. 655350 2011 01 18Saint John
NBC Covered Bond GP Inc. Canada SMSS Corporate Services (NB) Inc. 655353 2011 01 18Saint John
GreenSafe Demanufacturing Inc. Canada Robert W. Constable 655390 2011 01 19Fredericton
D.R. Pièces D’Autos Inc. Canada Luc J. Elsliger 655408 2011 01 19Moncton
Portland General Partner Inc. Ontario SMSS Corporate Services (NB) Inc. 655419 2011 01 21Saint John
101173849 SASKATCHEWAN LTD. Saskatchewan SMSS Corporate Services (NB) Inc. 655420 2011 01 21Saint John
Sherrard Legal Services Professional Ontario Alan D. Schelew 655432 2011 01 21Corporation Moncton
SANCON CONTRACTING LTD. Alberta Dennis Killoran 655436 2011 01 21Belledune
_____________________________________________________
iMARKETING SOLUTIONS GROUP INC. Xentel DM Incorporated 076518 2011 01 20
OUTSOURCING ARCHITECTS CANADA INC. 2027267 ONTARIO INC. 654752 2011 01 17
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment of registration of extra-provincial corporation has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification de l’enregistrement de corporationextraprovinciale a été émis à :
ReferenceNumber Date
Previous name Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Ancienne raison sociale référence année mois jour
The Royal Gazette — February 16, 2011 187 Gazette royale — 16 février 2011
BOSCH REXROTH CANADA Bosch Rexroth Canada Corp./ SMSS Corporate Services 655286 2011 01 14CORP. CORPORATION BOSCH Corporation Bosch Rexroth Canada (NB) Inc.REXROTH CANADA Saint John
InnVest Hotels GP Ltd. INNVEST HOTELS GP LTD. SMSS Corporate Services 655287 2011 01 14(NB) Inc.Saint John
InnVest Hotels GP XV Ltd. InnVest Hotels GP XV Ltd. SMSS Corporate Services 655288 2011 01 14(NB) Inc.Saint John
NCR Canada Ltd./ NCR CANADA LTD./ SMSS Corporate Services 655289 2011 01 14NCR Canada Ltee NCR CANADA LTÉE (NB) Inc.
Saint John
ROGERS BROADCASTING ROGERS BROADCASTING SMSS Corporate Services 655446 2011 01 24LIMITED LIMITED (NB) Inc.
Saint John
Fog City Rollers Inc. Saint John 655412 2011 01 20
CLUB DE BADMINTON DU NORD-OUEST INC. Edmundston 655508 2011 01 26
LA FONDATION ESCALE MADAVIC INC. Edmundston 655537 2011 01 27
The Westmorland Centre for Seniors Inc. Lakeville 655538 2011 01 27
LA FONDATION COMMUNAUTAIRE DES PIONNIERS ET Lamèque 655550 2011 01 28PIONNIERES INC.
_____________________________________________________
CANADIAN PARAPLEGIC ASSOCIATION Ability New Brunswick Inc./ 023719 2011 01 24(NEW BRUNSWICK) INC. Capacité Nouveau-Brunswick Inc.
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of amalgamated corporationhas been issued to the following extra-provincial corporations:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovincialeissue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales sui-vantes :
ReferenceAgent and Address Number Date
Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Représentant et Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes adresse référence année mois jour
Loi sur les compagniesCompanies ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,
letters patent have been granted to:SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres
patentes ont été émises à :
ReferenceNumber Date
Head Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Siège social référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,supplementary letters patent, which include a change in name,have been granted to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettrespatentes supplémentaires, contenant une nouvelle raison sociale,ont été émises à :
DateNew Name Reference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Nouvelle raison sociale Numéro de référence année mois jour
The Royal Gazette — February 16, 2011 188 Gazette royale — 16 février 2011
BATH SOLUTIONS OF 654541 N.B. Inc. Quispamsis 654807 2011 01 19SAINT JOHN
BATH SOLUTIONS OF 654541 N.B. Inc. Quispamsis 654808 2011 01 19FREDERICTON
Prime Rentals LPR INVESTMENTS LTD. Fredericton 654811 2011 01 14
King Street Trading Post CHIPPIN & DEWITT Fredericton 654812 2011 01 14ASSOCIATES, INC.
BARMAC LAWNS Durrell McIntosh Harvey 654967 2011 01 21
WYLIE’S WOODWORKING Philip Wylie Colpitts Settlement 655024 2011 01 27
G. Savoie Taxi Gerard Savoie Pont-Landry 655173 2011 01 24
POMODORI DUMAQ HOLDINGS INC. Rothesay 655250 2011 01 12
Downtown Electrical Contractors Andrey Milchenko Fredericton 655259 2011 01 18
BOIESTOWN OUTFITTING MIRAMICHI RIVER Boiestown 655260 2011 01 12LODGE RIGHTS INC.
D - BOB’S PUB Patricia Parsons Sackville 655282 2011 01 13
RD Prepress Solutions T & W HOLDINGS LIMITED Moncton 655298 2011 01 14
KLU’SKAP native art gallery Pascal A. Pelletier Moncton 655328 2011 01 17
Barney’s Auto Parts David Andrew Kelly Chipman 655334 2011 01 17
Linda Connexionplus Linda Landry-Guimond Fredericton 655335 2011 01 17
Simply You Simply You Ltd. Saint John 655351 2011 01 18
Cyr & fils mini entrepôt Danny Cyr Saint-Basile 655365 2011 01 18
MEDAXIO INSURANCE Medisys Insurance Medical Saint John 655380 2011 01 19MEDICAL SERVICES Services LP
MEDAXIO SERVICE DE Medisys Insurance Medical Saint John 655381 2011 01 19MÉDECINE Services LP
E.I.S. ELECTRICAL INSPECTION MARITIME ELECTRICAL Dieppe 655396 2011 01 19SERVICES CONSULTANTS AND
INVESTIGATIONS LTD.
Celebrations Event Planning Dexter Martin-Schedler Fredericton 655413 2011 01 20& Decor Rentals by Dexter
FIVE STAR EQUIPMENT SALES Yard Gear Sales & Service Inc. Hanwell 655414 2011 01 20
7th Heaven Lingerie 500716 N.B. LTD. Campbellton 655430 2011 01 21
Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des
appellations commercialesPartnerships and Business Names
Registration ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of business name hasbeen registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appel-lation commerciale a été enregistré :
Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour
The Royal Gazette — February 16, 2011 189 Gazette royale — 16 février 2011
Hampton Business Centre HAMPTON HOLDINGS INC. Hampton 655431 2011 01 21
ECLIPSE INNOVATIONS Anu Gupta Saint John 655434 2011 01 21
HEAL THY SELF Jenny L. Rowett Woodstock 655435 2011 01 21
Code Green Technology Services Stephen Gilbert Durham Bridge 655443 2011 01 21
Emfatik Health Strategies MAKE IT LAST INC. Salisbury 655452 2011 01 24
Arion Esthetics Krista Matchett Fredericton 655459 2011 01 24
The Cherry Lounge Salon Joanne Higginson Fredericton 655462 2011 01 24
Petstart Nutrition Center Kevin McClure Moncton 655463 2011 01 24
Monique Pearson Photography Monique Pearson Moncton 655464 2011 01 24
Clifton Woolens Elizabeth Miller Clifton Royal 655470 2011 01 25
CLASSIC WOODWORKING Hatt Enterprises (2010) Ltd. Oak Bay 655483 2011 01 25
KOK Campground H&J MULLIN HOLDINGS INC. Grande-Digue 655484 2011 01 25
GOOSEDOWN COTTAGE Mary Ellen Munroe Hampton 655487 2011 01 25
J. Levasseur Auto Service, Enr. Jeanel Levasseur Clair 655489 2011 01 25
All Creatures Spiral Journeys Dana Brouwer Colpitts Settlement 655491 2011 01 25
Mind Burst Marketing Shawn Mackay Lower Coverdale 655496 2011 01 26
T.W. Enterprises Lorne Goodwin Moncton 655518 2011 01 26
Drummond Built Auto Richard Drummond Fredericton 655521 2011 01 26
Red Eye Marketing Solutions Anne-Marie Boucher Shediac River 655530 2011 01 27
Health Affects Stephen LeBlanc Dumfries 655531 2011 01 27
EASY MOVE SJ Jeff Murray Quispamsis 655535 2011 01 27
WHIMSICAL MEMORIES Della Pitre Saint John 655540 2011 01 27WEDDING AND PARTY DESIGNS
GRAPHIQUES PUBLICI TECH Sylvie Losier Eel River Crossing 655541 2011 01 27VISION GRAPHICS
D-U-C Trucking Ulrike Doernenburg Woodstock 655544 2011 01 27
Lunenburg Insurance Agency Nova Insurance Ltd. Saint John 655551 2011 01 28
_____________________________________________________
KENT BUILDING SUPPLIES - J. D. IRVING, LIMITED Saint John 310138 2011 01 24VALLEY HOME CENTER STORE
SHIRLEY’S VARIETY Shirley LaPointe Nash Creek 312117 2011 01 21
ALTA MUSICA Louise Tardif Riverview 312562 2011 01 20
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of businessname has been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement d’appellation commerciale a été enregistré :
Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour
The Royal Gazette — February 16, 2011 190 Gazette royale — 16 février 2011
IMPRIMERIE-IMPRESSION COR-MAR LTD. Bathurst 325488 2011 01 24PRINTING
MADI’S EUROESTHETICS Maria Itoafa Fredericton 338737 2011 01 25
Atlantic Towing Atlantic Towing Limited Saint John 347068 2011 01 26Remorquage Atlantique Limitée
Percy’s Home Improvements Percy Jesso Rothesay 347248 2011 01 20
RJ SPAGNOL’S SPAGNOL’S WINE & BEER Fredericton 350712 2011 01 24MAKING SUPPLIES LTD.
PHH ARVAL PHH VEHICLE MANAGEMENT Saint John 350965 2011 01 24SERVICES INC./PHH SERVICESDE GESTION DE VEHICULESINC.
PPG Phillips Industrial Coatings PPG Canada Inc. Saint John 351038 2011 01 24
Phillips Paint Products PPG Canada Inc. Saint John 351039 2011 01 24
PRC-DeSoto Canada PPG Canada Inc. Saint John 351040 2011 01 24
DLL DE LAGE LANDEN Saint John 351079 2011 01 25FINANCIAL SERVICES CANADA INC.SERVICES FINANCIERS DE LAGE LANDEN CANADA INC.
Triple R Transport Triple R Telecom (2000) Ltd. Saint John 620323 2011 01 23
PHIL’S STORAGE PHIL’S AUTO & Lincoln 621133 2011 01 20RECREATION SALES, SERVICE & RENTALS LTD.
Baa-Sic Designs M. Ann Irving Saint John 622208 2011 01 26
Timco Property Services 048247 N. B. LTD. Fredericton 622498 2011 01 24
ROAD KING SALES 622424 N.B. Ltd. Fredericton 622531 2011 01 25
Bourque precision machining & Jean Bourque Memramcook 622535 2011 01 21Tooling
École de langue FRANCO-“FUN” Francine Babineau Saint-Louis de Kent 622630 2011 01 25
EAZY-GO CONSTRUCTION & Eugene Landry Memramcook 622635 2011 01 21RENOVATION
Bo-Claire Tissus Claire Cormier Grande-Anse 622760 2011 01 21
The Mill Pub Reesh Enterprises Ltd. Miramichi 622777 2011 01 26
CAMPBELL’S AUTO SALES CAMPBELL’S AUTO Riverview 622809 2011 01 24SALES LTD.
Mr. Graphic Denis Chiasson Dieppe 622818 2011 01 25
HENRY BIRKS & SONS BIRKS & MAYORS INC. Saint John 623860 2011 01 24
W.H.A.G. Financial Services Walter Allen Sackville 624021 2011 01 29
Saint John Sea Dogs Foundation SAINT JOHN HOCKEY Saint John 624179 2011 01 28FUND LTD.
East Point Developments East Point Inc. Saint John 624240 2011 01 27
Intuit Design Shelley Rogers Saint John 624493 2011 01 24
The Royal Gazette — February 16, 2011 191 Gazette royale — 16 février 2011
MIX DIRECT ROGERS BROADCASTING Saint John 640797 2011 01 24LIMITED
THE SHOPPING CHANNEL ROGERS BROADCASTING Saint John 640798 2011 01 24DIRECT LIMITED
THE SHOPPING CHANNEL ROGERS BROADCASTING Saint John 641980 2011 01 24LIMITED
Teva Teva Canada Limited/ Saint John 650330 2011 01 21Teva Canada Limitée
Teva Novopharm Teva Canada Limited/ Saint John 650332 2011 01 21Teva Canada Limitée
Novopharm Teva Canada Limited/ Saint John 650333 2011 01 21Teva Canada Limitée
Teva Canada Teva Canada Limited/ Saint John 650334 2011 01 21Teva Canada Limitée
_____________________________________________________
RAYTHEON CANADA Saint John 352584 2011 01 24
RAYTHEON SYSTEMS CANADA Saint John 353027 2011 01 24
Dari Delite Tasty Flavors Grand-Sault / Grand Falls 614800 2011 01 26
7th Heaven Lingerie Campbellton 622078 2011 01 21
IND FORESTRY Dieppe 629765 2011 01 25
METAFORE FINANCIAL SERVICES Saint John 635660 2011 01 26
Pemberton Plumbing Colpitts Settlement 635885 2011 01 25
KEVIN SAUNDERS CONSTRUCTION Quispamsis 636319 2011 01 26
The Candy Cottage McKinleyville 636925 2011 01 23
Fair Price Roofing Fredericton 643715 2011 01 24
FUNDY GREEN SUSTAINABLE PROPERTY DEVELOPMENTS Carters Point 644826 2011 01 21
INTEGRATED MEANING SYSTEM Bayswater 649929 2011 01 28
J. K. E. QUALITY HOMES Saint John 653879 2011 01 21
Absolute Childcare Shediac 654576 2011 01 25
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of cessation of busi-ness or use of business name has been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessa-tion de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation com-merciale a été enregistré :
ReferenceNumber Date
Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour
The Royal Gazette — February 16, 2011 192 Gazette royale — 16 février 2011
FERODOMINION 655227 N.B. Inc. Moncton 655273 2011 01 13655228 N.B. Inc.Fero Waste & Recycling Inc.
Cardinal Pomerleau General Partnership Cardinal Pomerleau Inc. Quispamsis 655394 2011 01 04Cardinal Pomerleau NPO Inc.
FUNDY SPORTS & TOURISM Garth Millar Saint John 655410 2011 01 26Helena Millar
Car-Buddies Detailing Cody Logan Getchell Fredericton 655450 2011 01 24Brad Chapman Patterson
_____________________________________________________
JAREA ART STUDIO/KINDERART Jantje Blokhuis-Mulder Saint Andrews 350865 2011 01 21Andrea Mulder-SlateGeoffrey David Slate
TELUS Communications Company TELE-MOBILE COMPANY Saint John 623611 2011 01 25TELUS COMMUNICATIONS INC.
_____________________________________________________
SEELY STREET BED AND BREAKFAST Saint John 633081 2011 01 20
CELGENE Toronto 635115 2011 01 21
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of partnership hasbeen registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de so-ciété en nom collectif a été enregistré :
Address of Business Referenceor Agent Number DateAdresse du commerce Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of part-nership has been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement de société en nom collectif a été enregistré :
Address ofBusiness or Agent ReferenceAdresse du Number Datecommerce ou Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Partners / Membres du représentant référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of dissolution of part-nership has been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de disso-lution de société en nom collectif a été enregistré :
ReferenceNumber Date
Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour
The Royal Gazette — February 16, 2011 193 Gazette royale — 16 février 2011
D+H Limited Partnership Saint John Colombie- SMSS Corporate Services 631128 2011 01 21Britannique / (NB) Inc.
British Saint JohnColumbia
MRF 2011 Resource Limited Saint John Alberta SMSS Corporate Services 655267 2011 01 13Partnership (NB) Inc.
Saint John
MAPLE LEAF SHORT DURATION Saint John Colombie- SMSS Corporate Services 655316 2011 01 172011 FLOW-THROUGH LIMITED Britannique / (NB) Inc.PARTNERSHIP British Saint John
Columbia
QWEST ENERGY 2011 FLOW- Saint John Colombie- SMSS Corporate Services 655354 2011 01 18LIMITED PARTNERSHIP Britannique / (NB) Inc.
British Saint JohnColumbia
Matrix 2011 - I National and Quebec Saint John Ontario SMSS Corporate Services 655378 2011 01 19Resource Flow Through LP (NB) Inc.
Saint John
Medisys Insurance Medical Saint John Ontario SMSS Corporate Services 655379 2011 01 19Services LP (NB) Inc.
Saint John
NBC COVERED BOND Saint John Ontario SMSS Corporate Services 655382 2011 01 19GUARANTOR LIMITED (NB) Inc.PARTNERSHIP Saint John
Sprott 2011 Flow-Through Saint John Ontario SMSS Corporate Services 655383 2011 01 19Limited Partnership (NB) Inc.
Saint John
_____________________________________________________
D+H Limited Partnership FILOGIX LIMITED Colombie- SMSS Corporate 631128 2011 01 21PARTNERSHIP Britannique / Services (NB) Inc.
British Saint JohnColumbia
_____________________________________________________
Loi sur les sociétés en commanditeLimited Partnership ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-
ship Act, a declaration of extra-provincial limited partnership hasbeen filed:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de société en commandite extraprovinciale a été dépo-sée par :
Principal place in ReferenceNew Brunswick Agent and Address Number DatePrincipal établissement au Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Nouveau-Brunswick Compétence et adresse référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of extra-provincial limited partnership,which includes a name change, has been filed:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de société en commandite extraprovinciale, contenantune nouvelle raison sociale, a été déposée par :
ReferenceAgent and Address Number Date
Previous Name Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Ancienne raison sociale Compétence et adresse référence année mois jour
The Royal Gazette — February 16, 2011 194 Gazette royale — 16 février 2011
Davis + Henderson, Limited Partnership Colombie-Britannique / SMSS Corporate Services 400618 2011 01 21British Columbia (NB) Inc.
Saint John
_____________________________________________________
Filogix Limited Partnership Ontario Davis + Henderson Saint John 631128 2011 01 21
LTS MANAGED Alberta LTS Solutions Ltd. Saint John 634319 2011 01 24TECHNICAL SERVICES LIMITED PARTNERSHIP
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of withdrawal of extra-provincial limitedpartnership has been filed:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de retrait de société en commandite extraprovinciale aété déposée par :
ReferenceAgent and Address Number Date
Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence et adresse référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of change of limited partnership or extra-provincial limited partnership has been filed:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de changement de société en commandite ou de sociétéen commandite extraprovinciale a été déposée :
Principal place in ReferenceNew Brunswick Number Date
Jurisdiction General Partners Principal établissement au Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Commandités Nouveau-Brunswick référence année mois jour
SALE OF MOTOR VEHICLESTake notice that the Registrar of Motor Vehicles, Province ofNew Brunswick, will be disposing of the following vehicles onor after February 16, 2011:
1984, Honda 750 MSSerial No. JH2RC1509EM102157License Plate: MC43073Registered Owner: Ryan MurphyVehicle located at Loyalist City Towing, Saint John
1982, Suzuki MSSerial No. JS1GP71A4C2102852License Plate: YBL53Registered Owner: Rick NichollsVehicle located at Loyalist City Towing, Saint John
2007, KONKER MFSerial No. L3BSENL007B010154License Plate: XR6279Registered Owner: Kyle MarsdenVehicle located at Loyalist City Towing, Saint John
Department ofPublic Safety
VENTE DE VÉHICULES À MOTEURSachez que le registraire des véhicules à moteur de la provincedu Nouveau-Brunswick mettra en vente les véhicules à moteursuivants le 16 février 2011 :
Motocyclette Honda 750 1984Numéro de série : JH2RC1509EM102157Numéro d’immatriculation : MC43073Propriétaire immatriculé : Ryan MurphyVéhicule se trouvant actuellement chez Loyalist CityTowing, Saint JohnMotocyclette Suzuki 1982Numéro de série : JS1GP71A4C2102852Numéro d’immatriculation : YBL53Propriétaire immatriculé : Rick NichollsVéhicule se trouvant actuellement chez Loyalist CityTowing, Saint JohnVélomoteur KONKER 2007Numéro de série : L3BSENL007B010154Numéro d’immatriculation : XR6279Propriétaire immatriculé : Kyle MarsdenVéhicule se trouvant actuellement chez Loyalist CityTowing, Saint John
Ministère de laSécurité publique
The Royal Gazette — February 16, 2011 195 Gazette royale — 16 février 2011
Motocyclette Honda CBR600 1999Numéro de série : JH2PC3528XM001196Numéro d’immatriculation : YGK51Propriétaire immatriculé : Timmy J. AlexanderVéhicule se trouvant actuellement chez Loyalist CityTowing, Saint John
Pontiac Grand Prix 2001Numéro de série : 1G2WK52J71F267159Numéro d’immatriculation : GWK780Propriétaire immatriculé : Patrick BrineVéhicule se trouvant actuellement chez George LegerTowing, ShediacFord Escort 1998Numéro de série : 3FAFP15P7WR271976Numéro d’immatriculation : Non-immatriculé-PEPropriétaire immatriculé : Charlotte C. CorbinVéhicule se trouvant actuellement chez George LegerTowing, Shediac
Avis public de changement de noms enregistrés enapplication de la Loi sur le changement de nom, lois du
Nouveau-Brunswick de 1987, c.C-2.001, par.9(1.1)
Ancien nom enregistré :Nouveau nom enregistré :Adresse :
Date d’accueil de la demande :
Hossein Motallebpoor-AlishahiHossien Alisha53, rue HopperMoncton (N.-B.) E1C 8Y2Le 16 décembre 2010
Ancien nom enregistré :Nouveau nom enregistré :Adresse :
Date d’accueil de la demande :
Syndia Marie DoucetCyndia Quirion79, rue ThériaultDieppe (N.-B.) E1A 7V8Le 17 décembre 2010
Ancien nom enregistré :Nouveau nom enregistré :Adresse :
Date d’accueil de la demande :
Terri Mae Elizabeth HunterTerri Mae Elizabeth Rice3503, route 625Boiestown (N.-B.) E6A 1C5Le 23 décembre 2010
Ancien nom enregistré :
Nouveau nom enregistré :Adresse :
Date d’accueil de la demande :
Terrence Cecil Clayton,Maxwell-RaynesTerrence Cecil Clayton Maxwell126, avenue CourtenaySaint John (N.-B.) E2J 1N5Le 29 décembre 2010
Josée DubéRegistraire générale des statistiques
de l’état civil
Services Nouveau-Brunswick
1999, Honda CBR600 MSSerial No. JH2PC3528XM001196License Plate: YGK51Registered Owner: Timmy J. AlexanderVehicle located at Loyalist City Towing, Saint John
2001, Pontiac Grand PrixSerial No. 1G2WK52J71F267159License Plate: GWK780Registered Owner: Patrick BrineVehicle located at George Leger Towing, Shediac
1998, Ford EscortSerial No. 3FAFP15P7WR271976License Plate: Unplated-PERegistered Owner: Charlotte C. CorbinVehicle located at George Leger Towing, Shediac
Public notice of change of registered nameunder the Change of Name Act, chapter C-2.001,
ss.9(1.1) of the acts of New Brunswick, 1987
Previous Registered Name:New Registered Name:Address:
Date Granted:
Hossein Motallebpoor-AlishahiHossien Alisha53 Hopper StreetMoncton, NB E1C 8Y2December 16, 2010
Previous Registered Name:New Registered Name:Address:
Date Granted:
Syndia Marie DoucetCyndia Quirion79 Thériault StreetDieppe, NB E1A 7V8December 17, 2010
Previous Registered Name:New Registered Name:Address:
Date Granted:
Terri Mae Elizabeth HunterTerri Mae Elizabeth Rice3503 Route 625Boiestown, NB E6A 1C5December 23, 2010
Previous Registered Name:
New Registered Name:Address:
Date Granted:
Terrence Cecil Clayton,Maxwell-RaynesTerrence Cecil Clayton Maxwell126 Courtenay AvenueSaint John, NB E2J 1N5December 29, 2010
Josée DubéRegistrar General of Vital Statistics
Service New Brunswick
The Royal Gazette — February 16, 2011 196 Gazette royale — 16 février 2011
Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)
To: Dotcom Marketing Group Inc., original Mortgagor; and toall others whom it may concern. Sale pursuant to terms of theMortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Actsin amendment thereof. Freehold property being situated at26-30 Cliff Street, Saint John, New Brunswick, the same lotconveyed to Dotcom Marketing Group Inc. by Transfer datedNovember 17, 2005 and registered in the Land Titles Office onDecember 8, 2005, as document number 21434825.
Notice of Sale given by Bank of Montreal as Mortgagee. Sale tobe held at Saint John Court House located at 110 CharlotteStreet, Saint John, New Brunswick on the 1st day of March,2011, at the hour of 11:00 a.m., local time. See advertisement ofNotice of Sale in the Telegraph-Journal dated February 1, Feb-ruary 8, February 15 and February 22, 2011.
McInnes Cooper, Solicitors for Bank of Montreal, Per: MathieuR. Poirier, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400,P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Tele-phone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095
________________
Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)
To: Shantel Marie James and Mark Durn James, original Mort-gagors; and to all others whom it may concern. Sale pursuant toterms of the Mortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973,c.P-19 and Acts in amendment thereof. Freehold property beingsituated at 26 Dewar Street, Saint John, New Brunswick, thesame lot conveyed to Shantel Marie James and Mark DurnJames by Transfer registered in the Land Titles Office on July29, 2009, as document number 27515650.
Notice of Sale given by Scotia Mortgage Corporation. Sale tobe held at Saint John Court House located at 110 CharlotteStreet, Saint John, New Brunswick on the 1st day of March,2011, at the hour of 11:15 a.m., local time. See advertisement ofNotice of Sale in the Telegraph-Journal dated February 1, Feb-ruary 8, February 15 and February 22, 2011.
McInnes Cooper, Solicitors for Scotia Mortgage Corporation,Per: Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, SuiteS400, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6,Telephone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095
________________
Sale of Lands Publication Act R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)
To: Hugo-Marc Quimpère and Marie-Josée Quimpère, Mort-gagors and owners of the equity of redemption; and all otherswhom it may concern. Sale under the terms of the mortgage andthe Property Act, R.S.N.B. 1973, c.P-19. Freehold property sit-uate at 1 Heritage Street, Kedgwick, Province of NewBrunswick, the said land corresponding to the same lot having
Notices of Sale
Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonceL.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2)
Destinataire : Dotcom Marketing Group Inc., débiteur hypothé-caire originaire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuéeen vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles dela Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenurelibre situés aux 26 et 30, rue Cliff, Saint John (Nouveau-Brunswick), et correspondant au même lot ayant été transféré àDotcom Marketing Group Inc. par l’acte de transfert établi le17 novembre 2005 et enregistré au bureau de l’enregistrementfoncier le 8 décembre 2005 sous le numéro 21434825.Avis de vente donné par la Banque de Montréal, créancière hy-pothécaire. La vente aura lieu le 1er mars 2011, à 11 h, heure lo-cale, au palais de justice de Saint John situé au 110, rue Char-lotte, Saint John (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiéedans les éditions des 1er, 8, 15 et 22 février 2011 du Telegraph-Journal.
Mathieu R. Poirier, du cabinet McInnes Cooper, avocats de laBanque de Montréal, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Main,bureau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick)E1C 8T6; téléphone : 506-857-8970, télécopieur : 506-857-4095
________________
Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonceL.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2)
Destinataires : Shantel Marie James et Mark Durn James, débi-teurs hypothécaires originaux; et tout autre intéressé éventuel.Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothè-que et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19.Biens en tenure libre situés au 26, rue Dewar, Saint John(Nouveau-Brunswick), et correspondant au même lot ayant ététransféré à Shantel Marie James et à Mark Durn James par l’actede transfert enregistré au bureau de l’enregistrement foncier le29 juillet 2009 sous le numéro 27515650.Avis de vente donné par la Société hypothécaire Scotia. Lavente aura lieu le 1er mars 2011, à 11 h 15, heure locale, au pa-lais de justice de Saint John situé au 110, rue Charlotte, SaintJohn (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans leséditions des 1er, 8, 15 et 22 février 2011 du Telegraph-Journal.
Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Sociétéhypothécaire Scotia, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Main, bu-reau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6;téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095
________________
Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces L.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2)
Destinataires : Hugo-Marc Quimpère et Marie-Josée Quimpère,débiteurs hypothécaires et propriétaires du droit de rachat; ettout autre intéressé éventuel. Vente effectuée conformémentaux dispositions de l’acte d’hypothèque et de la Loi sur lesbiens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au1, rue Heritage, Kedgwick, province du Nouveau-Brunswick,
Avis de vente
The Royal Gazette — February 16, 2011 197 Gazette royale — 16 février 2011
been conveyed to Hugo-Marc Quimpère and Marie-JoséeQuimpère by deed registered at the Registry Office on May 7,2004, as Number 18304668.
Notice of Sale given by the Bank of Nova Scotia, Mortgagee.Sale on March 3, 2011, at 1:00 p.m., local time, at theCampbellton Court House, 157 Water Street, Suite 202,Campbellton, New Brunswick. See notice of sale in theFebruary 2, 9, 16 and 23, 2011, editions of L’Acadie Nouvelle.
McInnes Cooper, Solicitors for the Bank of Nova Scotia,per Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, SuiteS400, P.O. Box 1368, Moncton, NB E1C 8T6, telephone: 506-857-8970, fax: 506-857-4095
________________
To: Robert Earle Hammond and Theresa Cecile Hammond,Mortgagor and owner of the equity of redemption, all of 3571Loch Lomond Road, Saint John, New Brunswick;
And To: All others whom it may concern.Freehold premises situate, lying and being at 3571 LochLomond Road, in the City of Saint John, in the Parish of SaintJohn, in the County of Saint John, and Province of NewBrunswick, more particularly described as PID 328443. Noticeof sale given by M & M MacNeil Developments Limited,holder of the first mortgage. Sale on the 10th day of March,2011, at 11:00 a.m., at the Saint John Court House at110 Charlotte Street, Saint John, New Brunswick. The Mort-gagee reserves the right to postpone or reschedule the time anddate of sale. See advertisement in the Telegraph-Journal.
Mark S. Sheehan, of McAllister Sheehan Law, Solicitors for theMortgagee, M & M MacNeil Developments Limited
________________
TO: RACHEL ERICA HUNTER and BOBBY CYROUELLETTE, of 13 Dube Street, Grand Falls, in the Countyof Victoria and Province of New Brunswick, Mortgagor;
AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN.Freehold premises known as PID 65194540, situate, lying andbeing at 13 Dube Street, Grand Falls, in the County of Victoriaand Province of New Brunswick.Notice of Sale given by the Toronto-Dominion Bank, holder ofthe first mortgage.Sale on the 16th day of March, 2011, at 11:00 a.m., at the GrandFalls Town Hall, 131 Pleasant Street, Grand Falls, NewBrunswick.See advertisement in the Victoria Star.Sale conducted under the terms of the mortgage and the Prop-erty Act, R.S.N.B., 1973, Chapter P-19, as amended.
lesdits biens correspondant au même lot ayant été transféré àHugo-Marc Quimpère et Marie-Josée Quimpère par Acte deTransfert enregistré au bureau d’enregistrement foncier le 7 mai2004 sous le numéro 18304668.Avis de vente donné par La Banque de Nouvelle-Écosse, créan-cière hypothécaire. La vente aura lieu le 3 mars 2011 à 13 h,heure locale, au Palais de Justice de Campbellton, 157, rueWater, pièce 202, Campbellton (Nouveau-Brunswick). Voirl’avis de vente publié dans les éditions de L’Acadie Nouvelle du2 février, 9 février, 16 février et 23 février 2011.
McInnes Cooper, avocats de La Banque de Nouvelle-Écosse,par Adel Gönczi, Centre Croix Bleue, 644, rue Main, pièceS400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6,téléphone : 506-857-8970, télécopieur : 506-857-4095
________________
Destinataires : Robert Earle Hammond et Theresa CecileHammond, débiteurs hypothécaires et propriétaires du droit derachat, tous deux du 3571, chemin Loch Lomond, Saint John(Nouveau-Brunswick);Et tout autre intéressé éventuel.Lieux en tenure libre situés au 3571, chemin Loch Lomond,ville de Saint John, paroisse de Saint John, comté de Saint John,province du Nouveau-Brunswick, et dont le numéro d’identifi-cation est 328443. Avis de vente donné par M & M MacNeilDevelopments Limited, titulaire de la première hypothèque. Lavente aura lieu le 10 mars 2011, à 11 h, au palais de justice deSaint John, 110, rue Charlotte, Saint John (Nouveau-Brunswick). Le créancier hypothécaire se réserve le droit de re-porter la date et l’heure de la vente. Voir l’annonce publiée dansle Telegraph-Journal.
Mark S. Sheehan, du cabinet McAllister Sheehan Law, avocatsdu créancier hypothécaire, M & M MacNeil DevelopmentsLimited
________________
DESTINATAIRES : RACHEL ERICA HUNTER etBOBBY CYR OUELLETTE, du 13, rue Dubé, Grand-Sault,comté de Victoria, province du Nouveau-Brunswick, débiteurshypothécaires;ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.Lieux en tenure libre situés au 13, rue Dubé, Grand-Sault,comté de Victoria, province du Nouveau-Brunswick, et dont lenuméro d’identification est 65194540.Avis de vente donné par La Banque Toronto-Dominion, titu-laire de la première hypothèque.La vente aura lieu le 16 mars 2011, à 11 h, à l’hôtel de ville deGrand-Sault, 131, rue Pleasant, Grand-Sault (Nouveau-Brunswick).Voir l’annonce publiée dans le Victoria Star.Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothè-que et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, chapitreP-19.
The Royal Gazette — February 16, 2011 198 Gazette royale — 16 février 2011
DATED at the City of Moncton, in the County of Westmorlandand Province of New Brunswick, this 2nd day of February, 2011.
WILBUR & WILBUR, Solicitors for the Mortgagee, TheToronto-Dominion Bank
________________
TO: KAREN OUELLET, of 457 Des Pionniers Avenue,Balmoral, in the County of Restigouche and Province of NewBrunswick, Mortgagor;AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN.Freehold premises known as PID 50150689 and 50183813, sit-uate, lying and being at 457 Des Pionniers Avenue, Balmoral,in the County of Restigouche and Province of New Brunswick.Notice of Sale given by the Toronto-Dominion Bank, holder ofthe first mortgage.Sale on the 18th day of March, 2011, at 11:00 a.m., at the CourtHouse in Campbellton, 157 Water Street, Campbellton,Restigouche County, New Brunswick.See advertisement in The Tribune.Sale conducted under the terms of the mortgage and the Prop-erty Act, R.S.N.B., 1973, Chapter P-19, as amended.
DATED at the City of Moncton, in the County of Westmorlandand Province of New Brunswick, this 2nd day of February, 2011.
WILBUR & WILBUR, Solicitors for the Mortgagee, TheToronto-Dominion Bank
The Royal Gazette is published every Wednesday under theauthority of the Queen’s Printer Act. Documents must be re-ceived by the Royal Gazette Coordinator, in the Queen’sPrinter Office, no later than noon, at least seven days prior toWednesday’s publication. Each document must be separatefrom the covering letter. Signatures on documents must be im-mediately followed by the printed name. The Queen’s Printermay refuse to publish a document if any part of it is illegible,and may delay publication of any document for administrativereasons.Prepayment is required for the publication of all documents.Standard documents have the following set fees:
NoticesCost perInsertion
Notice of the intention to apply for the enactment of a private bill
$ 20
Originating process $ 25Order of a court $ 25Notice under the Absconding Debtors Act $ 20Notice under the General Rules under the Law Society Act,
1996, of disbarment or suspension or of application forreinstatement or readmission
$ 20
Notice of examination under the Licensed Practical NursesAct
$ 25
Notice under the Motor Carrier Act $ 30
Notice to Advertisers
FAIT dans la ville de Moncton, comté de Westmorland, pro-vince du Nouveau-Brunswick, le 2 février 2011.
WILBUR & WILBUR, avocats de la créancière hypothécaire,La Banque Toronto-Dominion
________________
DESTINATAIRE : KAREN OUELLET, du 457, avenue desPionniers, Balmoral, comté de Restigouche, province duNouveau-Brunswick, débitrice hypothécaire;ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.Lieux en tenure libre situés au 457, avenue des Pionniers,Balmoral, comté de Restigouche, province du Nouveau-Brunswick, et dont les NID sont 50150689 et 50183813.Avis de vente donné par La Banque Toronto-Dominion, titu-laire de la première hypothèque.La vente aura lieu le 18 mars 2011, à 11 h, au palais de justicede Campbellton, 157, rue Water, Campbellton, comté deRestigouche, province du Nouveau-Brunswick.Voir l’annonce publiée dans le journal The Tribune.Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothè-que et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, chapitreP-19.FAIT dans la ville de Moncton, comté de Westmorland, pro-vince du Nouveau-Brunswick, le 2 février 2011.
WILBUR & WILBUR, avocats de la créancière hypothécaire,La Banque Toronto-Dominion
La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformé-ment à la Loi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents àpublier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazetteroyale, au bureau de l’Imprimeur de la Reine, à midi, aumoins sept jours avant le mercredi de publication. Chaqueavis doit être séparé de la lettre d’envoi. Les noms des signa-taires doivent suivre immédiatement la signature. L’Impri-meur de la Reine peut refuser de publier un avis dont une par-tie est illisible et retarder la publication d’un avis pour desraisons administratives.Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis.Voici les tarifs pour les avis courants :
AvisCoût par parution
Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loid’intérêt privé
20 $
Acte introductif d’instance 25 $Ordonnance rendue par une cour 25 $Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite 20 $Avis de radiation ou de suspension ou de demande de
réintégration ou de réadmission, exigé par les Règlesgénérales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur leBarreau
20 $
Avis d’examen exigé par la Loi sur les infirmières etinfirmiers auxiliaires autorisés
25 $
Avis exigé par la Loi sur les transports routiers 30 $
Avis aux annonceurs
The Royal Gazette — February 16, 2011 199 Gazette royale — 16 février 2011
Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque ormoney order (payable to the Minister of Finance). No refundswill be issued for cancellations.
The official version of The Royal Gazette is available freeon-line each Wednesday. This free on-line service replaces theprinted annual subscription service. The Royal Gazette can beaccessed on-line at:
http://www.gnb.ca/0062/gazette/index-e.asp
Print-on-demand copies of The Royal Gazette are available, atthe Office of the Queen’s Printer, at $4.00 per copy plus 13%tax, plus shipping and handling where applicable.
Office of the Queen’s Printer670 King Street, Room 117
P.O. Box 6000Fredericton, NB E3B 5H1
Tel: 506-453-2520 Fax: 506-457-7899E-mail: gazette@gnb.ca
Any document under the Political Process Financing Act $ 20
Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9under the Probate Court Act
$ 20
Notice under the Quieting of Titles Act (Form 70B)Note: Survey Maps cannot exceed 8.5″ x 14″
$120
Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is1/2 page in length or less
$ 20
Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice isgreater than 1/2 page in length
$ 75
Any document under the Winding-up and Restructuring Act(Canada)
$ 20
Notice of a correction charge isthe same as
for publishing the original document
Any other document $3.50 for each cm or less
Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte decrédit MasterCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (établià l’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement nesera effectué en cas d’annulation.
La version officielle de la Gazette royale est disponible gra-tuitement et en ligne chaque mercredi. Ce service gratuit enligne remplace le service d’abonnement annuel. Vous trouve-rez la Gazette royale à l’adresse suivante :
http://www.gnb.ca/0062/gazette/index-f.asp
Nous offrons, sur demande, des exemplaires de la Gazetteroyale, au bureau de l’Imprimeur de la Reine, pour la sommede 4 $ l’exemplaire, plus la taxe de 13 %, ainsi que les fraisapplicables de port et de manutention.
Bureau de l’Imprimeur de la Reine670, rue King, pièce 117
C.P. 6000Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1Tél. : 506-453-2520 Téléc. : 506-457-7899
Courriel : gazette@gnb.ca
Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur lefinancement de l’activité politique
20 $
Avis aux créanciers exigé par le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour dessuccessions
20 $
Avis exigé par la Loi sur la validation des titres de propriété(Formule 70B)
Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 posur 14 po
120 $
Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est d’une demi-page ou moins enlongueur
20 $
Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est de plus d’une demi-page enlongueur
75 $
Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur lesliquidations et les restructurations (Canada)
20 $
Avis d’une correction les frais sont les mêmes que ceux imposés
pour la publication du
document original
Tout autre document 3,50 $ pour chaque cm ou
moins
QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK
All rights reserved / Tous droits réservés
top related