the royal gazette / gazette royale (16/05/25) · bathurst, à compter du 7 avril 2016, pour un...

25
The Royal Gazette Fredericton New Brunswick Gazette royale Fredericton Nouveau-Brunswick Vol. 174 Wednesday, May 25, 2016 / Le mercredi 25 mai 2016 629 ISSN 1714-9428 Notice to Readers The Royal Gazette is officially published on-line. Except for formatting, documents are published in The Royal Gazette as submitted. Material submitted for publication must be received by the Royal Gazette Coordinator no later than noon, at least 7 working days prior to Wednesday’s publication. However, when there is a public holiday, please contact the Royal Gazette Coordinator. APRIL 7, 2016 2016-80 1. Under paragraph 4(1)(c) and subsections 4(3), 5(1) and 5(3) of the Premier’s Council on the Status of Disabled Persons Act, the Lieutenant-Governor in Council reappoints Linda Ferrier, Fredericton, New Brunswick, as a member of the Premier’s Council on the Status of Disabled Persons, representing the Public at Large, effective April 7, 2016, for a term ending Sep- tember 15, 2017. 2. Under paragraph 4(1)(a) and subsections 4(3), 5(1) and 5(3) of the Premier’s Council on the Status of Disabled Persons Act, the Lieutenant-Governor in Council reappoints Noëlla Hébert, Saint-Louis de Kent, New Brunswick, as a member of the Pre- mier’s Council on the Status of Disabled Persons, representing Orders in Council Avis aux lecteurs La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne. Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans la Gazette royale tels que soumis. Les documents à publier doivent parvenir à la coordonna- trice de la Gazette royale, à midi, au moins 7 jours ou- vrables avant le mercredi de publication. En cas de jour férié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de la Gazette royale. LE 7 AVRIL 2016 2016-80 1. En vertu de l’alinéa 4(1)c) et des paragraphes 4(3), 5(1) et 5(3) de la Loi créant le Conseil du premier ministre sur la condition des personnes handicapées, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour un nouveau mandat Linda Ferrier, de Fredericton (Nouveau-Brunswick), membre du Conseil du pre- mier ministre sur la condition des personnes handicapées, à titre de représentante du public, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se terminant le 15 septembre 2017. 2. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des paragraphes 4(3), 5(1) et 5(3) de la Loi créant le Conseil du premier ministre sur la condition des personnes handicapées, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour un nouveau mandat Noëlla Hébert, de Saint-Louis-de-Kent (Nouveau-Brunswick), membre du Décrets en conseil

Upload: others

Post on 11-Oct-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: The Royal Gazette / Gazette royale (16/05/25) · Bathurst, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se termi-nant le 15 septembre 2017. 6. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des

The RoyalGazette

FrederictonNew Brunswick

Gazetteroyale

FrederictonNouveau-Brunswick

Vol. 174 Wednesday, May 25, 2016 / Le mercredi 25 mai 2016 629

ISSN 1714-9428

Notice to Readers

The Royal Gazette is officially published on-line.

Except for formatting, documents are published in TheRoyal Gazette as submitted.

Material submitted for publication must be received bythe Royal Gazette Coordinator no later than noon, at least7 working days prior to Wednesday’s publication.However, when there is a public holiday, please contactthe Royal Gazette Coordinator.

APRIL 7, 20162016-80

1. Under paragraph 4(1)(c) and subsections 4(3), 5(1) and 5(3)of the Premier’s Council on the Status of Disabled Persons Act,the Lieutenant-Governor in Council reappoints Linda Ferrier,Fredericton, New Brunswick, as a member of the Premier’sCouncil on the Status of Disabled Persons, representing thePublic at Large, effective April 7, 2016, for a term ending Sep-tember 15, 2017.

2. Under paragraph 4(1)(a) and subsections 4(3), 5(1) and 5(3)of the Premier’s Council on the Status of Disabled Persons Act,the Lieutenant-Governor in Council reappoints Noëlla Hébert,Saint-Louis de Kent, New Brunswick, as a member of the Pre-mier’s Council on the Status of Disabled Persons, representing

Orders in Council

Avis aux lecteurs

La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne.

Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dansla Gazette royale tels que soumis.

Les documents à publier doivent parvenir à la coordonna-trice de la Gazette royale, à midi, au moins 7 jours ou-vrables avant le mercredi de publication. En cas de jourférié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de laGazette royale.

LE 7 AVRIL 20162016-80

1. En vertu de l’alinéa 4(1)c) et des paragraphes 4(3), 5(1) et5(3) de la Loi créant le Conseil du premier ministre sur lacondition des personnes handicapées, le lieutenant-gouverneuren conseil nomme pour un nouveau mandat Linda Ferrier, deFredericton (Nouveau-Brunswick), membre du Conseil du pre-mier ministre sur la condition des personnes handicapées, à titrede représentante du public, à compter du 7 avril 2016, pour unmandat se terminant le 15 septembre 2017.2. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des paragraphes 4(3), 5(1) et5(3) de la Loi créant le Conseil du premier ministre sur lacondition des personnes handicapées, le lieutenant-gouverneuren conseil nomme pour un nouveau mandat Noëlla Hébert, deSaint-Louis-de-Kent (Nouveau-Brunswick), membre du

Décrets en conseil

Page 2: The Royal Gazette / Gazette royale (16/05/25) · Bathurst, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se termi-nant le 15 septembre 2017. 6. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des

The Royal Gazette — May 25, 2016 630 Gazette royale — 25 mai 2016

the Miramichi Region, effective April 7, 2016, for a term end-ing September 15, 2017.

3. Under paragraph 4(1)(a) and subsections 4(3), 5(1) and 5(3)of the Premier’s Council on the Status of Disabled Persons Act,the Lieutenant-Governor in Council reappoints MichaelGeorge, Saint John, New Brunswick, as a member of the Pre-mier’s Council on the Status of Disabled Persons, representingthe Saint John Region, effective April 7, 2016, for a term endingSeptember 15, 2017.

4. Under paragraph 4(1)(b) and subsections 4(3) and 5(3) of thePremier’s Council on the Status of Disabled Persons Act, theLieutenant-Governor in Council appoints Amelia Barry, SaintJohn, New Brunswick, as a member of the Premier’s Council onthe Status of Disabled Persons, representing a ProvincialAgency which works on behalf of disabled persons or repre-sents disabled persons, effective April 7, 2016, for a term end-ing September 14, 2017.

5. Under paragraph 4(1)(a) and subsections 4(3) and 5(3) of thePremier’s Council on the Status of Disabled Persons Act, theLieutenant-Governor in Council appoints Marc LeBlanc,Beresford, New Brunswick, as a member of the Premier’sCouncil on the Status of Disabled Persons, representing theBathurst Region, effective April 7, 2016, for a term ending Sep-tember 15, 2017.

6. Under paragraph 4(1)(a) and subsections 4(3) and 5(3) of thePremier’s Council on the Status of Disabled Persons Act, theLieutenant-Governor in Council appoints Gerald MacPherson,Fredericton, New Brunswick, as a member of the Premier’sCouncil on the Status of Disabled Persons, representing theFredericton Region, effective April 7, 2016, for a term endingSeptember 15, 2017.

7. Under paragraph 4(1)(c) and subsections 4(3) and 5(3) of thePremier’s Council on the Status of Disabled Persons Act, theLieutenant-Governor in Council appoints Dawn Stevens,Fredericton, New Brunswick, as a member of the Premier’sCouncil on the Status of Disabled Persons, representing thePublic at Large, effective April 7, 2016, for a term ending Sep-tember 15, 2017.

8. Under paragraph 4(1)(a) and subsections 4(3) and 5(3) of thePremier’s Council on the Status of Disabled Persons Act, theLieutenant-Governor in Council appoints Michèle Ouellette,Edmundston, New Brunswick, as a member of the Premier’sCouncil on the Status of Disabled Persons, representing theEdmundston Region, effective November 25, 2016, for a termof two years.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor

________________

Conseil du premier ministre sur la condition des personnes han-dicapées, à titre de représentante de la région de Miramichi, àcompter du 7 avril 2016, pour un mandat se terminant le 15 sep-tembre 2017.3. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des paragraphes 4(3), 5(1) et5(3) de la Loi créant le Conseil du premier ministre sur lacondition des personnes handicapées, le lieutenant-gouverneuren conseil nomme pour un nouveau mandat Michael George, deSaint John (Nouveau-Brunswick), membre du Conseil du pre-mier ministre sur la condition des personnes handicapées, à titrede représentant de la région de Saint John, à compter du 7 avril2016, pour un mandat se terminant le 15 septembre 2017.4. En vertu de l’alinéa 4(1)b) et des paragraphes 4(3) et 5(3) dela Loi créant le Conseil du premier ministre sur la condition despersonnes handicapées, le lieutenant-gouverneur en conseilnomme Amelia Barry, de Saint John (Nouveau-Brunswick),membre du Conseil du premier ministre sur la condition despersonnes handicapées, à titre de représentante d’une agencequi travaille au nom des personnes handicapées ou les repré-sente, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se terminantle 14 septembre 2017.5. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des paragraphes 4(3) et 5(3) dela Loi créant le Conseil du premier ministre sur la condition despersonnes handicapées, le lieutenant-gouverneur en conseilnomme Marc LeBlanc, de Beresford (Nouveau-Brunswick),membre du Conseil du premier ministre sur la condition despersonnes handicapées, à titre de représentant de la région deBathurst, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se termi-nant le 15 septembre 2017.6. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des paragraphes 4(3) et 5(3) dela Loi créant le Conseil du premier ministre sur la condition despersonnes handicapées, le lieutenant-gouverneur en conseilnomme Gerald MacPherson, de Fredericton (Nouveau-Brunswick), membre du Conseil du premier ministre sur lacondition des personnes handicapées, à titre de représentant dela région de Fredericton, à compter du 7 avril 2016, pour unmandat se terminant le 15 septembre 2017.7. En vertu de l’alinéa 4(1)c) et des paragraphes 4(3) et 5(3) dela Loi créant le Conseil du premier ministre sur la condition despersonnes handicapées, le lieutenant-gouverneur en conseilnomme Dawn Stevens, de Fredericton (Nouveau-Brunswick),membre du Conseil du premier ministre sur la condition despersonnes handicapées, à titre de représentante du public, àcompter du 7 avril 2016, pour un mandat se terminant le 15 sep-tembre 2017.8. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des paragraphes 4(3) et 5(3) dela Loi créant le Conseil du premier ministre sur la condition despersonnes handicapées, le lieutenant-gouverneur en conseilnomme Michèle Ouellette, d’Edmundston (Nouveau-Brunswick), membre du Conseil du premier ministre sur lacondition des personnes handicapées, à titre de représentante dela région d’Edmundston, à compter du 25 novembre 2016, pourun mandat de deux ans.

La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

________________

Page 3: The Royal Gazette / Gazette royale (16/05/25) · Bathurst, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se termi-nant le 15 septembre 2017. 6. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des

The Royal Gazette — May 25, 2016 631 Gazette royale — 25 mai 2016

APRIL 7, 20162016-81

1. Under subsection 3(1) of the Atlantic Provinces Special Ed-ucation Authority Agreement provided for under the Educationof Aurally and Visually Handicapped Persons Act, theLieutenant-Governor in Council appoints Stephanie Warren,Chaplin Island Road, New Brunswick, as a member of theBoard of Directors of the Atlantic Provinces Special EducationAuthority effective April 7, 2016, for a term of two years.

2. Under subsection 3(1) of the Atlantic Provinces Special Ed-ucation Authority Agreement provided for under the Educationof Aurally and Visually Handicapped Persons Act, theLieutenant-Governor in Council reappoints Nancy Boucher,Fredericton, New Brunswick, as a member of the Board of Di-rectors of the Atlantic Provinces Special Education Authorityeffective April 7, 2016, for a term of two years.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor

________________

APRIL 27, 20162016-97

Under section 12 of the Public Works Act, the Lieutenant-Governor in Council gives approval for the Minister of Trans-portation and Infrastructure to convey the property described inSchedule “A” hereto attached, known as the Val D’Amour firehall and land, to the Village of Atholville for the purchase priceof $1.00.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor

To obtain a complete copy, please refer to the ExecutiveCouncil Office Website for Orders-in-Council.

________________

APRIL 27, 20162016-99

Under paragraph 2(1)(c) and subsection 3(2) of the Labour andEmployment Board Act, the Lieutenant-Governor in Council re-appoints the following persons as members of the Labour andEmployment Board, for a term of three years, effective April 27,2016:

(a) Marie-Ange Losier, Beresford, New Brunswick, as arepresentative of employees;(b) Jean-Guy Lirette, Shediac, New Brunswick, as a repre-sentative of employers;(c) Gloria Clark, Saint John, New Brunswick, as a represen-tative of employers; and(d) Stephen Beatteay, Saint John, New Brunswick, as a rep-resentative of employers.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor

________________

LE 7 AVRIL 20162016-81

1. En vertu du paragraphe 3(1) de l’Entente relative à l’Officede l’éducation spéciale pour les provinces de l’Atlantique éta-blie en vertu de la Loi sur l’enseignement aux handicapés del’ouïe et de la vue, le lieutenant-gouverneur en conseil nommeStephanie Warren, de Chaplin Island Road (Nouveau-Brunswick), membre du conseil d’administration de la Com-mission de l’enseignement spécial des provinces de l’Atlan-tique, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat de deux ans.2. En vertu du paragraphe 3(1) de l’Entente relative à l’Officede l’éducation spéciale pour les provinces de l’Atlantique éta-blie en vertu de la Loi sur l’enseignement aux handicapés del’ouïe et de la vue, le lieutenant-gouverneur en conseil nommepour un nouveau mandat Nancy Boucher, de Fredericton,(Nouveau-Brunswick), membre du conseil d’administration dela Commission de l’enseignement spécial des provinces del’Atlantique, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat de deuxans.

La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

________________

LE 27 AVRIL 20162016-97

En vertu de l’article 12 de la Loi sur les travaux publics, lelieutenant-gouverneur en conseil autorise le ministre des Trans-ports et de l’Infrastructure à céder au Village d’Atholville, encontrepartie de 1 $, le bien désigné à l’annexe « A » ci-jointe,connu comme la caserne de pompiers de Val-d’Amour et le ter-rain sur lequel elle se trouve.

La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

Pour recevoir un exemplaire au complet, veuillezconsulter le site Web du bureau du Conseil exécutif.

________________

LE 27 AVRIL 20162016-99

En vertu de l’alinéa 2(1)c) et du paragraphe 3(2) de la Loi sur laCommission du travail et de l’emploi, le lieutenant-gouverneuren conseil nomme pour un nouveau mandat les personnes sui-vantes membres de la Commission du travail et de l’emploi,pour un mandat de trois ans, à compter du 27 avril 2016 :

a) Marie-Ange Losier, de Beresford (Nouveau-Brunswick), à titre de représentante des employés;b) Jean-Guy Lirette, de Shediac (Nouveau-Brunswick), àtitre de représentant des employeurs;c) Gloria Clark, de Saint John (Nouveau-Brunswick), àtitre de représentante des employeurs; etd) Stephen Beatteay, de Saint John (Nouveau-Brunswick),à titre de représentant des employeurs.

La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

________________

Page 4: The Royal Gazette / Gazette royale (16/05/25) · Bathurst, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se termi-nant le 15 septembre 2017. 6. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des

The Royal Gazette — May 25, 2016 632 Gazette royale — 25 mai 2016

APRIL 27, 20162016-101

Under section 12 of the Public Works Act, the Lieutenant-Governor in Council gives approval for the Minister of Trans-portation and Infrastructure to:

(a) purchase the residential property (PIDs 25156084,25105305 and 25356676) located in Cocagne, NewBrunswick, for the appraised value of $103,000 plus agreedexpenses. The total disbursement to be $120,000 and will bewithdrawn from the Land Management Fund;

(b) dispose of the surplus property located on Twin OaksRoad (PD 70569454), located in Moncton, New Brunswick,and(c) deposit the proceeds from the sale of the Twin OaksRoad property (PID 70569454) to the credit of the LandManagement Fund.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor

________________

APRIL 27, 20162016-102

Under section 12 of the Public Works Act, the Lieutenant-Governor in Council gives approval for the Minister of Trans-portation and Infrastructure to convey former DNR surplusproperty (vacant land) located on Route 102, Kingsclear, NewBrunswick, as described in Schedule “A”, to 688916 N.B. Inc.,Fredericton, New Brunswick, for the purchase price of$176,300.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor

To obtain a complete copy, please refer to the ExecutiveCouncil Office Website for Orders-in-Council.

LE 27 AVRIL 20162016-101

En vertu de l’article 12 de la Loi sur les travaux publics, lelieutenant-gouverneur en conseil autorise le ministre des Trans-ports et de l’Infrastructure à :

a) acquérir l’immeuble résidentiel (NID 25156084,25105305 et 25356676) situé à Cocagne, au Nouveau-Brunswick, pour la valeur d’expertise de 103 000 $ plus lesdépenses convenues, le décaissement total, s’élevant à120 000 $, devant être prélevé sur le Fonds pour l’aménage-ment des terres;b) disposer du bien excédentaire situé chemin Twin Oaks(NID 70569454), à Moncton, au Nouveau-Brunswick, et

c) porter le produit de la vente du bien du chemin TwinOaks (NID 70569454) au crédit du Fonds pour l’aménage-ment des terres.

La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

________________

LE 27 AVRIL 20162016-102

En vertu de l’article 12 de la Loi sur les travaux publics, lelieutenant-gouverneur en conseil autorise le ministre des Trans-ports et de l’Infrastructure à céder à 688916 N.B. Inc., deFredericton (Nouveau-Brunswick), en contrepartie de176 300 $, l’ancien bien excédentaire du ministère des Res-sources naturelles (terrain vacant) désigné à l’annexe « A », si-tué route 102, à Kingsclear, au Nouveau-Brunswick.

La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

Pour recevoir un exemplaire au complet, veuillezconsulter le site Web du bureau du Conseil exécutif.

Kinfolk Executive Auto Sales Incorporated Saint John 688487 2016 05 03

689051 NB Ltd. Indian Island 689051 2016 04 26

Precision Properties Inc. Rusagonis 689086 2016 04 27

689090 N.B. Ltd. Saint John 689090 2016 04 27

Atlantic Martial Arts Academy Inc. Fredericton 689091 2016 04 27

689093 NB INC. Haut-Sheila 689093 2016 04 27

Loi sur les corporations commercialesBusiness Corporations Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of incorporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commer-ciales, un certificat de constitution en corporation a été émis à :

ReferenceNumber Date

Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

Page 5: The Royal Gazette / Gazette royale (16/05/25) · Bathurst, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se termi-nant le 15 septembre 2017. 6. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des

The Royal Gazette — May 25, 2016 633 Gazette royale — 25 mai 2016

689095 NB INC. Haut-Sheila 689095 2016 04 27

Peter Burns Logging Ltd. Sackville 689096 2016 04 27

CLIFTON ROYAL DOG BOARDING KENNELS LTD. Clifton Royal 689097 2016 04 27

689098 NB Ltd. Clifton Royal 689098 2016 04 27

Fiddlehead Casket Company Ltd. Fredericton 689103 2016 04 27

689107 N.B. Inc. Saint John 689107 2016 04 28

J.R.B.O. Entreprises Inc. Bertrand 689118 2016 04 28

TBar Restaurant Inc. Balmoral 689119 2016 04 28

Pêcheries Jimmy R. Inc. LeGoulet 689120 2016 04 28

Darren Keith Contractor Inc. Apohaqui 689122 2016 04 28

Spring Roots Early Learning and Child Care Centre Incorporated Killarney Road 689123 2016 04 28

Elite Snow Removal Inc. McQuade 689124 2016 04 28

R & C Plourde Corp. Richibucto Road 689126 2016 04 28

Camerise Benoit Inc. Benoit 689127 2016 04 28

Famille Marc Poirier Holdings Inc. Balmoral 689128 2016 04 28

THREE SISTERS FISHERIES LTD. Pokeshaw 689129 2016 04 28

689133 NB Inc. Fredericton 689133 2016 04 28

Westmorland Alarm Inc. Dorchester 689137 2016 04 28

Famille Ghislain Lepage Holdings Inc. Balmoral 689140 2016 04 28

ENERGIES RENOUVELABLE RESTIGOUCHE RENEWABLE ENERGIES INC.

McLeods 689143 2016 04 28

Billy & Brandy Alward Trucking Inc. Salisbury 689145 2016 04 28

Old Church Cottages Inc. Lutes Mountain 689146 2016 04 28

689149 NB INC. Perth-Andover 689149 2016 04 29

AtlanticCan Pilots & Services Ltd. French Lake 689150 2016 04 29

Boulay Construction Inc. Saint-Quentin 689151 2016 04 29

Kamaud Properties Inc. Memramcook 689154 2016 04 29

Westmount-DuParc Properties Inc. Moncton 689157 2016 04 29

Sky Squad Moncton Inc. Moncton 689163 2016 04 29

OGTJOOSN WIND FARM 1A INC. / PARC ÉOLIEN OGTJOOSN 1A INC.

Indian Island 689164 2016 04 29

689165 N.B. Inc. Fredericton 689165 2016 04 29

OGTJOOSN WIND FARM 1B INC. / PARC ÉOLIEN OGTJOOSN 1B INC.

Indian Island 689167 2016 04 29

Pierre Côté Mécanique (2016) Ltée Inkerman-Ferry 689168 2016 04 29

689169 NB Inc. Shediac 689169 2016 04 29

Dial Rental Ltd. Dieppe 689170 2016 04 29

Mini Asian Noodle Takeout Inc. Moncton 689171 2016 04 29

Page 6: The Royal Gazette / Gazette royale (16/05/25) · Bathurst, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se termi-nant le 15 septembre 2017. 6. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des

The Royal Gazette — May 25, 2016 634 Gazette royale — 25 mai 2016

NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUMBusiness Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales

In relation to a certificate of incorporation issued on May 4, 2016 under the name of “689253 N.B. Corp.”, being corporation #689253, notice isgiven that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation, correcting the postal code to E5J 2S9.

Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 4 mai 2016 à « 689253 N.B. Corp. », dont le numéro de corporationest 689253, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé corrigeant le code postal pour qu’il se lise E5J 2S9.

_____________________________________________________

In relation to a certificate of incorporation issued on May 9, 2016 under the name of “RÉSIDENCES L’HÉRITAGE DE L’ACADIE INC.”, beingcorporation #689329, notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting thename of the corporation from “RÉSIDENCES L’HÉRITAGE DE L’ACADIE INC.” to “RÉSIDENCE L’HÉRITAGE DE L’ACADIE INC.”.

Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 9 mai 2016 à « RÉSIDENCES L’HÉRITAGE DE L’ACADIEINC. » dont le numéro de corporation est 689329, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé faisant passerle nom de la corporation de « RÉSIDENCES L’HÉRITAGE DE L’ACADIE INC. » à « RÉSIDENCE L’HÉRITAGE DE L’ACADIE INC. ».

_____________________________________________________

LLOYD FRANCIS ELECTRICAL INC. Saint John 689172 2016 04 29

Houlie’s Hometown Pub Inc. Fredericton 689178 2016 05 02

Rayzen Innovations Inc. Fredericton 689179 2016 05 02

689180 N.B. Inc. Rothesay 689180 2016 05 02

Asi Architectural Metals Inc. Moncton 689181 2016 05 02

Annuaire NMS Directory Inc. Edmundston 689186 2016 05 02

Les Pêcheries F.N.N.M. Inc. Tracadie-Sheila 689194 2016 05 02

Mercer Logging Ltd. Riverbank 689195 2016 05 02

Signature Ventures Inc. Esteys Bridge 689199 2016 05 03

689205 N.B. INC. Fredericton 689205 2016 05 03

A AND J BUCKLEY INVESTMENTS LTD. Saint John 689206 2016 05 03

LeBreton Enterprise Inc. Fredericton 689209 2016 05 03

GUY ROBICHAUD TRANSPORT INC. Pointe-à-Tom 689216 2016 05 03

689217 N.B. INC. Shediac 689217 2016 05 03

689223 NB INC. Tilley Road 689223 2016 05 03

JCM Fisheries Ltd. Pennfield 689224 2016 05 03

689226 N.B. Inc. Boudreau-Ouest 689226 2016 05 03

689227 N.B. Inc. Boudreau-Ouest 689227 2016 05 03

689229 N.B. INC. Dieppe 689229 2016 05 03

DevCur Holdings Ltd. Burtts Corner 689230 2016 05 03

WIGGINS INSURANCE AGENCY INC. Sussex 689232 2016 05 04

Page 7: The Royal Gazette / Gazette royale (16/05/25) · Bathurst, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se termi-nant le 15 septembre 2017. 6. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des

The Royal Gazette — May 25, 2016 635 Gazette royale — 25 mai 2016

039687 N. B. LTD. 039687 2016 04 27

ALBERT LANDRY MATERIAUX DE CONSTRUCTION LTEE 049662 2016 04 29

SPATARO HOLDINGS LTD. 050662 2016 04 28

ICHIBOSHI L.P.C. LTD. 051560 2016 04 28

SOLOMON HOLDINGS INC. 059377 2016 04 29

502616 NB LTEE 502616 2016 05 02

Loch Lomond Motors Inc. 611203 2016 04 27

AUCTION TRANSPORT SERVICES INC. 619542 2016 04 27

630794 N.B. INC. 630794 2016 04 27

Siteimprove Inc. 680934 2016 04 28

Ancient Moon Living and Services Inc. 687814 2016 04 27

_____________________________________________________

GLM Holdings Ltd. 508966 N.B. Ltd. 508966 2016 05 03

ATLANTIC SITE SOLUTIONS LTD. PLACE 815 BOMBARDIER LTÉE 511086 2016 04 29

Peter J. Beardsworth Law Office and Beardsworth Mediation Inc.

BEARDSWORTH MEDIATION INC. 645057 2016 05 03

675724 NB Inc. The Washing Racoon Inc. /Le Raton Laveur Inc.

675724 2016 04 28

685932 NB Ltd MINI ASIAN NOODLE TAKEOUT LTD. 685932 2016 04 29

Solutions Assurances 360 Inc. / 360 Insurance Solutions Inc.

SOLUTIONS D’ASSURANCES 360 DEGREE/360 DEGREE INSURANCE SOLUTIONS INC.

685941 2016 04 28

PeakForm Health and Safety Academy Inc. 687480 NB Inc. 687480 2016 05 02

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment which includes a change inname has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification contenant un changement de raisonsociale a été émis à :

DatePrevious name Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour

Page 8: The Royal Gazette / Gazette royale (16/05/25) · Bathurst, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se termi-nant le 15 septembre 2017. 6. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des

The Royal Gazette — May 25, 2016 636 Gazette royale — 25 mai 2016

Uris Williams & Fils Ltée-Uris Williams & Sons Ltd.

URIS WILLIAMS ET FILS LTÉE – URIS WILLIAMS & SONS LTD.688331 NB LTD.

Moncton 689066 2016 04 28

W. SMITH & CO. LTD. SPICER-SMITH & CO. LTD.600360 N.B. LTD.681819 N.B. Inc.

Quispamsis 689084 2016 05 01

J.L. BREAU CRANE RENTALS LTD. J.L. BREAU CRANE RENTALS LTD.674755 NB Inc.

Bois-Gagnon 689085 2016 05 01

Heritage Resources Inc. HOLMES LAKE LODGE LTD.MARITIME AIRWAYS INC.HERITAGE ESTATES LTD.HERITAGE RESOURCES INC.Paquet Textiles Inc.

Moncton 689114 2016 05 01

Covey Office Group Inc. COVEY OFFICE GROUP INC.D. S. D. INVESTMENTS INC.688985 N.B. Inc.

Fredericton 689121 2016 05 01

Tire E.T. Hausse Levage et Halage de Maisons Ltée

E. T. & D. CONSTRUCTION & SOUDURE WELDING LTÉE/LTDTIRE E.T. HAUSSE LEVAGE ET HALAGE DE MAISONS LTÉE

Bertrand 689153 2016 05 01

SUSSEX EXCAVATORS (2010) LTD. SUSSEX EXCAVATORS (2010) LTD.SUSSEX DIRECTIONAL DRILLING INC.

Sussex 689160 2016 04 30

MCGRATH PHARMACIES INC. Northern Carleton Pharmacy (1999) Ltd.McGrath Pharmacies Inc.

Lower Knoxford 689211 2016 05 03

_____________________________________________________

BIRMINGHAM PARK INC. Fredericton 040455 2016 04 28

DUNGARVON CAMP ASSOCIATION LTD. Ammon 503185 2016 04 29

GESTION GILLES SINCLAIR INC. Charlo 604758 2016 04 29

Molto Italiano Film Productions Inc. Fredericton 613551 2016 04 28

616054 N.B. INC. Saint John 616054 2016 04 27

A. Foreman Consulting Inc. New Maryland 646760 2016 04 28

Advanced Digital Hearing Aid Centre Ltd. Rothesay 647952 2016 04 30

DR. WJB SHEARER, DDS PROFESSIONAL CORPORATION Miramichi 678799 2016 04 28

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amalgamation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de fusion a été émis à :

ReferenceNumber Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Registered Office Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes Bureau enregistré référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of dissolution has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de dissolution a été émis à :

ReferenceNumber Date

Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

Page 9: The Royal Gazette / Gazette royale (16/05/25) · Bathurst, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se termi-nant le 15 septembre 2017. 6. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des

The Royal Gazette — May 25, 2016 637 Gazette royale — 25 mai 2016

DOCTEURE M. KALIM CORPORATION PROFESSIONNELLE

Québec / Quebec 679018 2016 04 14

_____________________________________________________

MILLIGAN’S CYCLE WORKS INC. 513948 2016 04 29

KYLAH’S AUTO SALES & LEASING LTD. 514043 2016 05 03

Kennebecasis Denture Clinic Inc. 610744 2016 04 27

613096 N.B. Inc. 613096 2016 04 27

CHARTER’S TRAVEL AND CRUISE CENTER LTD. 622127 2016 04 28

BO Shipping Company Limited 631978 2016 05 02

638297 N.B. Ltd. 638297 2016 04 29

LANGILLE PLUMBING & HEATING LTD. 670709 2016 04 28

_____________________________________________________

LE-VEL BRANDS CANADA INC. Colombie-Britannique /British Columbia

Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

687229 2016 04 26

ANDMAR ECO-ENERGY INC. Canada Andy DominiqueGreater Lakeburn

689131 2016 04 28

MERIDIAN ONECAP CREDIT CORP. Ontario Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

689202 2016 05 03

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of discontinuance has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de cessation a été émis à :

DateJurisdiction of Continuance Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Compétence de prorogation Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of revival has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de reconstitution a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of extra-provincial corporationhas been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a étéémis à :

ReferenceNumber Date

Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour

Page 10: The Royal Gazette / Gazette royale (16/05/25) · Bathurst, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se termi-nant le 15 septembre 2017. 6. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des

The Royal Gazette — May 25, 2016 638 Gazette royale — 25 mai 2016

Colliers Project Leaders Inc. Colliers Maîtres de projets inc.

MHPM PROJECT MANAGERS INC. PM GESTION DE PROJETS INC.

638353 2016 04 28

M30 RETAIL SERVICES, ULC North America MerchandisingServices Canada ULC

662056 2016 04 26

ECHELON WEALTH PARTNERS INC. Euro Pacific Canada Inc. 686710 2016 04 25

NASDAQ CORPORATE SOLUTIONS CANADA ULC

MAICLAIR HOLDINGS ULC 687943 2016 04 28

_____________________________________________________

Network Telsys Inc. Alberta Adel GöncziMoncton

614708 2016 05 02 2016 07 31

Labatt Brewing Company Inc./La Brasserie Labatt Inc.

Ontario Willard M. JenkinsSaint John

652046 2016 05 02 2016 07 31

BLOOMBERG TRADEBOOK LLC Delaware Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc.Saint John

655131 2016 05 02 2016 07 31

Bloomberg Tradebook (Bermuda) Ltd.

Bermudes / Bermuda Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc.Saint John

655132 2016 05 02 2016 07 31

SWISSPORT CANADA INC. Canada Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc.Saint John

667898 2016 05 02 2016 07 31

Klingspor Inc. Canada Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc.Saint John

674263 2016 05 02 2016 07 31

REDMOND HEARTH INC. Ontario Aaron M. SavageFredericton

674946 2016 05 02 2016 07 31

FreshEx, Inc. Canada Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc.Saint John

678883 2016 05 02 2016 07 31

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment of registration of extra-provincial corporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification de l’enregistrement de corporationextraprovinciale a été émis à :

ReferenceNumber Date

Previous name Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Ancienne raison sociale référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, the Director has made a decision to cancel the registrationof the following extra-provincial corporations:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,le Directeur a décidé d’annuler l’enregistrement des corporations ex-traprovinciales suivantes :

Proposed CancellationReference Notice Date Date / Date deNumber Date de l’avis l’annulation projetée

Jurisdiction Agent Numéro de Year Month Day Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant référence année mois jour année mois jour

Page 11: The Royal Gazette / Gazette royale (16/05/25) · Bathurst, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se termi-nant le 15 septembre 2017. 6. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des

The Royal Gazette — May 25, 2016 639 Gazette royale — 25 mai 2016

DRA Americas Inc. Canada Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc.Saint John

682296 2016 05 02 2016 07 31

_____________________________________________________

ESF LIMITED/ESF LIMITEE Canada William H. TeedSaint John

074507 2016 05 01

FIN-XO valeurs mobilières inc. / FIN-XO Securities Inc.

Canada Steven D. ChristieFredericton

614381 2016 05 01

Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated Missouri Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc.Saint John

656759 2016 05 01

_____________________________________________________

HYNDMAN TRANSPORT LIMITED

HYNDMAN TRANSPORT (1972) LIMITED

Josh J.B. McElmanSaint John

689010 2016 04 25

OPGI MANAGEMENT GP INC./GESTION OPGI GP INC.

OPGI MANAGEMENT GP INC./GESTION OPGI GP INC.

McInnes Cooper CSDServices Inc.Saint John

689033 2016 04 25

METROPOLITAN CREDIT ADJUSTERS LTD.

METROPOLITAN CREDIT ADJUSTERS LTD.

John W. MacLennanMoncton

689064 2016 04 26

COOPER INDUSTRIES (ELECTRICAL) INC.

Cooper Industries (Electrical) Inc. Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John

689081 2016 04 27

FIRSTCANADA ULC FIRSTCANADA ULC Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John

689109 2016 04 28

PUBLIC NOTICE is hereby given, under the Business CorporationsAct, of the cancellation of the registration of the following extra-provincial corporations:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un avis d’annulation a été émis aux corporations extraprovincialessuivantes :

ReferenceNumber Date

Jurisdiction Agent Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of amalgamated corporationhas been issued to the following extra-provincial corporations:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovincialeissue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales sui-vantes :

ReferenceAgent and Address Number Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Représentant et Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes adresse référence année mois jour

Page 12: The Royal Gazette / Gazette royale (16/05/25) · Bathurst, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se termi-nant le 15 septembre 2017. 6. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des

The Royal Gazette — May 25, 2016 640 Gazette royale — 25 mai 2016

WOMEN FOR ATLANTIC FOUNDATION INC. Fredericton 689104 2016 04 27

_____________________________________________________

BEAR ISLAND CEMETERY INC. 677203 2016 04 23

_____________________________________________________

CLUB D’AGE D’OR DE NOTRE DAME DE KENT, INC. 022175 2016 05 03

Crystalhead Tattoo Crystal MacPherson Fredericton 686169 2016 04 28

Philips Canada PHILIPS ELECTRONICS LTDPHILIPS ELECTRONIQUE LTEE

Fredericton 688646 2016 04 27

CURTIS ABILITY ADJUSTMENT Jeffrey Curtis Doaktown 688891 2016 04 19

E.B.’s Esthetics Shop Erica Boyd Fredericton 688924 2016 04 20

Business Complete Pro Business Complete ProNBS Inc.

Grand-Barachois 689012 2016 04 25

Loi sur les compagniesCompanies ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,

letters patent have been granted to:SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres

patentes ont été émises à :

ReferenceNumber Date

Head Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Siège social référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,supplementary letters patent have been granted to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettrespatentes supplémentaires ont été émises à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that the charter of the followingcompany is revived under subsection 35.1(1) of the Companies Act:

SACHEZ que la charte de la compagnie suivante est reconstituéeen vertu du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les compagnies :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des

appellations commercialesPartnerships and Business Names

Registration ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and

Business Names Registration Act, a certificate of business name hasbeen registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appel-lation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Page 13: The Royal Gazette / Gazette royale (16/05/25) · Bathurst, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se termi-nant le 15 septembre 2017. 6. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des

The Royal Gazette — May 25, 2016 641 Gazette royale — 25 mai 2016

ECN - EXECUTIVE CONSULTING NETWORK

Eagle TemporaryStaffing Inc.

Saint John 689025 2016 04 25

FRED ZONE DELIVERY Lee Mitchell Fredericton 689026 2016 04 28

Très’Art Tracadie Annette Bénard Tracadie 689027 2016 05 03

SAPPORO BREWING COMPANY SLEEMAN BREWERIES LTD.BRASSERIES SLEEMAN LTÉE

Saint John 689030 2016 04 25

Toron Asset Management International

TORON CAPITAL MARKETS INC.

Fredericton 689031 2016 04 25

Blue’s Printing Shop IMPRIMERIE MODERNE 2010 INC.

Grand-Sault /Grand Falls

689062 2016 04 26

ASHAMA: Association Haïtienne des Maritimes

Sancia DoretAmanda EdmondMacGregore BrunisLionel Révolus

Moncton 689063 2016 04 26

Jay Pro Light Trucking & Mini Excavating

Jason Prosser Berryton 689079 2016 04 27

MORGAN’S TOTAL FOOT CARE Morgan Lee Johnston Penobsquis 689087 2016 04 27

Mike Allott Builders Michael Eric Allott Fredericton 689092 2016 04 27

AMOH Conference Fund Yves Leger Moncton 689094 2016 04 27

Wanderlust Caravan Bar Jennifer Ward Moncton 689100 2016 04 27

SAMs Burger Bar Callie Canrinus Sussex 689101 2016 04 27

The Renovation Zone Graeme Robichaud Moncton 689102 2016 04 27

G & R MOTOR SPORTS Sheldon Vickers Hanwell 689105 2016 04 28

Sandy Hill Farms Marc Legault Fords Mills 689106 2016 04 28

QM Environmental QM LP Saint John 689108 2016 04 28

Topaz Special Care Home 686935 NB LTD. Norton 689112 2016 04 28

East Coast Oral Surgery Dr. N. Daniel P.C. Inc. Moncton 689115 2016 04 28

Moncton Oral Surgery Dr. N. Daniel P.C. Inc. Moncton 689116 2016 04 28

Capital Dental Clinic Dr. Nachaat G.Daniel P.C. Inc.

Fredericton 689117 2016 04 28

WAY UP STRATEGIC SOLUTIONS Christine Gilliland Saint John 689125 2016 04 28

DUI PUBLICATIONS FENETY MARKETING SERVICES (Atlantic) Ltd.

Moncton 689130 2016 04 28

Morland Tech Christian Bouchard Moncton 689135 2016 04 28

Sérénité CK Fitness Chantal Duplessis Saint-Édouard-de-Kent 689136 2016 04 28

HERITAGE ESTATES Heritage Resources Inc. Moncton 689142 2016 05 01

Triple J Welding Chauncey Jardine Quarryville 689144 2016 04 28

École de violon Mélodia Nadia Bérubé-LeBlanc Fredericton 689147 2016 04 28

Home2Yoga Carrie Barker Saint Andrews 689148 2016 04 28

Advanced Digital Hearing Aid Centre

HELIX HEARING INC. Fredericton 689152 2016 04 30

HILLSIDE NATURAL GARDENS Jeffrey Graves Boundary Creek 689156 2016 04 29

Page 14: The Royal Gazette / Gazette royale (16/05/25) · Bathurst, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se termi-nant le 15 septembre 2017. 6. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des

The Royal Gazette — May 25, 2016 642 Gazette royale — 25 mai 2016

NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUMPartnerships and Business Names Registration Act / Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

In relation to the certificate of business name registered on April 7, 2016 under the Act, under the name of “Farevally Power Sports Sales & Ser-vice”, being file #688681, notice is given that pursuant to s.17 of the Act, the Registrar has ordered that the business name be corrected to read asfollows: “Farevalley Power Sports Sales & Service”.

Sachez que, relativement à un certificat d’appellation commerciale enregistré le 7 avril 2016 en vertu de la Loi sous le nom de « Farevally PowerSports Sales & Service », dont le numéro d’appellation commerciale est 688681, le registraire a ordonné, conformément à l’article 17 de la Loi, quel’appellation commerciale soit corrigée pour qu’elle se lise comme suit : « Farevalley Power Sports Sales & Service ».

_____________________________________________________

BELL’S FUNERAL SERVICE BELL’S FUNERAL HOME LTD. Miramichi 689158 2016 04 30

Kings Church The Wesleyan Church Quispamsis 689161 2016 05 02

Caron Metal Works Guy Caron Transport Ltée Saint-Quentin 689162 2016 05 01

Happy Endings Construction Randall Hannah Fredericton 689166 2016 04 29

Octopus Consulting & Management

Aurélia Jourdan Edmundston 689174 2016 04 30

Mi’kmaq Mama Enterprises Cheyenne Mary Mundleville 689175 2016 05 02

ME AND THE MRS. ANTIQUE AND COLLECTIBLES

Clara Thomas Norton 689176 2016 05 02

Heels in the Field Interior E-design

Kimberley Hnatyshyn Moncton 689177 2016 05 02

WILCOX WAREHOUSING AND DISTRIBUTION SERVICE

Brent Wilcox Saint John 689182 2016 05 02

Chalk about it refurbished Furniture

Mélanie Bélanger Moncton 689183 2016 05 02

Summer Scoops Paula Donahue Ammon 689190 2016 05 02

Curran Technology Matthew Curran St. Stephen 689196 2016 05 02

Meridian OneCap MERIDIAN ONECAP CREDIT CORP.

Saint John 689203 2016 05 03

Pauls Painting Paul Mercer Grand Manan 689204 2016 05 03

Lock Stock and Barrels Pub & Restaurant

Robert Palmer Saint John 689207 2016 05 03

Val Brooks Farm Gerard Levesque Edmundston 689208 2016 05 03

Northern Carleton Pharmacy MCGRATH PHARMACIES INC. Florenceville-Bristol 689212 2016 05 03

POUTINE GALORE Danielle Belisle Seeleys Cove 689214 2016 05 03

A.C. BUSINESS MANAGEMENT Angela Cameron South Esk 689236 2016 05 04

Page 15: The Royal Gazette / Gazette royale (16/05/25) · Bathurst, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se termi-nant le 15 septembre 2017. 6. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des

The Royal Gazette — May 25, 2016 643 Gazette royale — 25 mai 2016

BREUVAGE IDEAL ENREGISTRE Dorina Thériault-Haché Paquetville 328371 2016 04 30

TRILEAF DISTRIBUTION/DISTRIBUTION

CANADIAN TIRE CORPORATION,LIMITED

Saint John 333596 2016 05 02

MASTERCRAFT CANADA CANADIAN TIRE CORPORATION,LIMITED

Saint John 339082 2016 05 02

MOTOMASTER CANADA CANADIAN TIRE CORPORATION,LIMITED

Saint John 339084 2016 05 02

TAX ACTION Mondata Inc. Richibucto 339887 2016 05 03

GARDEN CLUB CANADA CANADIAN TIRE CORPORATION,LIMITED

Saint John 341307 2016 05 02

CANADIAN PREMIER PAINTS CANADIAN TIRE CORPORATION,LIMITED

Saint John 344653 2016 05 02

PARTSOURCE CANADIAN TIRE CORPORATION,LIMITED

Saint John 353128 2016 05 02

HERO CANADA CANADIAN TIRE CORPORATION,LIMITED

Saint John 353129 2016 05 02

YARDWORKS CANADA CANADIAN TIRE CORPORATION,LIMITED

Saint John 353130 2016 05 02

OXFORD PROPERTIES GROUP OPGI MANAGEMENT GP INC./GESTION OPGI GP INC.

Saint John 600137 2016 04 25

PERSONA CANADA CANADIAN TIRE CORPORATION,LIMITED

Saint John 600499 2016 05 02

E.F.G. Hébert Construction Enr. Guy Hébert Saint-Simon 616878 2016 04 25

Bathurst Massage Therapy Clinic Gordon Jacques Bathurst 617736 2016 05 03

Triple R Transport Triple R Telecom (2000) Ltd. Saint John 620323 2016 05 01

HUNTER DOUGLAS HUNTER DOUGLAS CANADA LIMITED PARTNERSHIP

Fredericton 624214 2016 05 03

HUNTER DOUGLAS CANADA HUNTER DOUGLAS CANADA LIMITED PARTNERSHIP

Fredericton 624215 2016 05 03

HUNTER DOUGLAS WINDOW FASHIONS

HUNTER DOUGLAS CANADA LIMITED PARTNERSHIP

Fredericton 624216 2016 05 03

HUNTER DOUGLAS FABRICATION

HUNTER DOUGLAS CANADA LIMITED PARTNERSHIP

Fredericton 624217 2016 05 03

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of businessname has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement d’appellation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Page 16: The Royal Gazette / Gazette royale (16/05/25) · Bathurst, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se termi-nant le 15 septembre 2017. 6. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des

The Royal Gazette — May 25, 2016 644 Gazette royale — 25 mai 2016

HUNTER DOUGLAS WINDOW FASHIONS CANADA

HUNTER DOUGLAS CANADA LIMITED PARTNERSHIP

Fredericton 624218 2016 05 03

HUNTER DOUGLAS CONTRACT WINDOW COVERINGS

HUNTER DOUGLAS CANADA LIMITED PARTNERSHIP

Fredericton 624219 2016 05 03

HUNTER DOUGLAS CANADA LP HUNTER DOUGLAS CANADA LIMITED PARTNERSHIP

Fredericton 624220 2016 05 03

HUNTER DOUGLAS CANADA L.P. HUNTER DOUGLAS CANADA LIMITED PARTNERSHIP

Fredericton 624221 2016 05 03

ELAN FINANCIAL SERVICES U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION

Saint John 625707 2016 04 29

Seltik Imports Shaun Johnston Moncton 644118 2016 05 03

True North Outfitters Kory Leslie Letang 654474 2016 04 27

Salon De Toilettage Canin IDEFIX Line Larocque Paquetville 655324 2016 04 25

Barclays Capital Barclays CapitalCanada Inc.

Saint John 657228 2016 05 02

Superior Gas Liquids Superior Gas LiquidsPartnership

Moncton 657347 2016 04 28

WIDIA KENNAMETAL LTD. Saint John 657406 2016 05 02

_____________________________________________________

KINGS VALLEY WESLEYAN CHURCH Quispamsis 309026 2016 05 02

BELL’S FUNERAL SERVICE Newcastle 338485 2016 04 30

NORTHERN ESCAPE CANADA Saint John 343108 2016 05 02

CARIS Fredericton 347383 2016 05 03

NORWOOD HILLS COLLECTION Saint John 349760 2016 05 02

PRODUITS DT PRODUCTS Saint John 621028 2016 05 02

Billy-Joe Alward Trucking Salisbury 626111 2016 04 27

First Class Home Interior Trim Moncton 640212 2016 04 29

Garrison District Ale House Fredericton 641227 2016 04 29

WESTMORLAND ALARM SERVICE Dorchester 648776 2016 04 28

Lloyd Francis Electrical Saint John 665553 2016 05 04

Hang Nail Esthetics Fredericton 667518 2016 04 29

Mercer Logging Riverbank 679947 2016 05 03

Summer Scoops Moncton 681378 2016 05 01

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of cessation of busi-ness or use of business name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessa-tion de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation com-merciale a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour

Page 17: The Royal Gazette / Gazette royale (16/05/25) · Bathurst, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se termi-nant le 15 septembre 2017. 6. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des

The Royal Gazette — May 25, 2016 645 Gazette royale — 25 mai 2016

Porter’s Land Management McLaughlin 683059 2016 05 03

Blue’s Printing Shop Grand-Sault / Grand Falls 688459 2016 04 26

_____________________________________________________

CCR Atlantic Community Homes & Support

Charline DymentCharles Robichaud

Memramcook 688981 2016 04 22

CURIOUS KIDS Child Care Ruth L. ClaybournAngela L. Prime

Fredericton 689061 2016 04 26

SELCOM SYSTEMS Carol JoubertDe Beer WillemMarthinus

Saint John 689065 2016 04 26

Chasin’ Tail Bar & Grill Melissa ButlandKelsey Williams

Alma 689111 2016 04 28

_____________________________________________________

SCA Partnership SCIERIES CHALEUR ASSOCIES/CHALEUR SAWMILLS ASSOCIATES

Belledune 333549 2016 04 28

_____________________________________________________

Poirault Service Traiteur Bertrand 678373 2016 04 28

Fiddlehead Caskets Fredericton 685942 2016 04 28

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of partnership hasbeen registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de so-ciété en nom collectif a été enregistré :

Address of Business Referenceor Agent Number DateAdresse du commerce Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of change of firmname has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de chan-gement de raison sociale a été enregistré :

Address ofBusiness or Agent ReferenceAdresse du Number Date

Previous Name commerce ou Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Ancienne raison sociale du représentant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of dissolution of part-nership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de disso-lution de société en nom collectif a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour

Page 18: The Royal Gazette / Gazette royale (16/05/25) · Bathurst, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se termi-nant le 15 septembre 2017. 6. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des

The Royal Gazette — May 25, 2016 646 Gazette royale — 25 mai 2016

CFP LUMBER LIMITED PARTNERSHIP

CFP Lumber GP Inc. Saint John 675721 2016 04 28

Ogtjoosn Mi’kmaq First Nations 1A Limited Partnership

689051 NB Ltd. Indian Island 689138 2016 04 28

Ogtjoosn Mi’kmaq First Nations 1B Limited Partnership

689052 NB Ltd. Indian Island 689139 2016 04 28

_____________________________________________________

CFP LUMBER LIMITED PARTNERSHIP

Chaleur Forest Products Limited Partnership

CFP Lumber GP Inc. 675721 2016 04 28

_____________________________________________________

CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP – SOCIÉTÉ EN COMMANDITE CANADELLE

Saint John Québec /Quebec

Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John

400413 2016 04 27

Avrio Ventures Limited Partnership II

Fredericton Alberta McInnes Cooper CSDServices Inc.Fredericton

657385 2016 04 27

EnerCare Solutions Limited Partnership

Saint John Ontario Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John

657860 2016 04 26

Loi sur les sociétés en commanditeLimited Partnership ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-

ship Act, a declaration of limited partnership has been filed by:SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une

déclaration de société en commandite a été déposée par :

Principal place in ReferenceNew Brunswick Number Date

General Partners Principal établissement au Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Commandités Nouveau-Brunswick référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of limited partnership, which includes aname change, has been filed by:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de société en commandite, contenant une nouvelle raisonsociale, a été déposée par :

ReferenceNumber Date

Previous Name General Partners Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Ancienne raison sociale Commandités référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of extra-provincial limited partnership hasbeen filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de société en commandite extraprovinciale a été dépo-sée par :

Principal place in ReferenceNew Brunswick Agent and Address Number DatePrincipal établissement au Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Nouveau-Brunswick Compétence et adresse référence année mois jour

Page 19: The Royal Gazette / Gazette royale (16/05/25) · Bathurst, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se termi-nant le 15 septembre 2017. 6. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des

The Royal Gazette — May 25, 2016 647 Gazette royale — 25 mai 2016

Sachez que Andrew Speight, un employé du ministère del’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, a éténommé Directeur des normes d’emploi pour la période du22 août 2016 au 26 août 2016, en vertu du paragraphe 45(2) dela Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois duNouveau-Brunswick de 1985.

________________

Sachez que Mireille Saulnier, une employée du ministère del’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, a éténommé Directrice des normes d’emploi pour la période du25 juillet 2016 au 29 juillet 2016 et du 29 août 2016 au 2 sep-tembre 2016, en vertu du paragraphe 45(2) de la Loi sur lesnormes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985.

À VENDREAncien Nashwaak Villa/Centre de santé de Stanley

32, route 620, StanleyComté de York (N.-B.)

Situé dans le village de Stanley, sur un lot d’environ 2,49 hec-tares (6,15 acres), ce bien contient l’ancien Centre de santé deStanley, avec une superficie d’environ 331 mètres carrés;(3 566 pieds carrés) au rez-de-chaussée, ainsi que l’ancienNashwaak Villa avec une superficie d’environ 1 413 mètres car-rés; (15 208 pieds carrés) au rez-de-chaussée. NID 01524859,01525120 et 75261321. Pour l’inspection, communiquer avecle ministère des Transports et de l’Infrastructure au 506-476-2417.

Valeur du bien : 150 000 $Date de fermeture : le 06 juin 2016

Pour les conditions de soumission contacter ou consulter :http://www.gnb.ca/2221/index-f.asp

Appeler : 506-453-2221Par courriel : [email protected]

Mentionner : l’appel d’offres no 17-L0023

Le ministre des Transports et de l’InfrastructureL’Hon. Roger Melanson

Ministère de l’Éducationpostsecondaire, de la

Formation et du Travail

Ministère des Transportset de l’Infrastructure

Notice is hereby given that Andrew Speight, an employee ofthe Department of Post-Secondary Education, Training and La-bour, is appointed Director of Employment Standards for theperiod of August 22nd, 2016 to August 26th, 2016, under au-thority of Subsection 45(2) of the Employment Standards Act,Chapter E-7.2 of the Statutes of New Brunswick 1985.

________________

Notice is hereby given that Mireille Saulnier, an employee ofthe Department of Post-Secondary Education, Training and La-bour, is appointed Director of Employment Standards for theperiod of July 25th, 2016 to July 29th, 2016 and August 29th,2016 to September 2nd, 2016, under authority of Subsection45(2) of the Employment Standards Act, Chapter E-7.2 of theStatutes of New Brunswick 1985.

FOR SALEFormer Nashwaak Villa/Stanley Health Centre

32 Route 620, StanleyYork County, N.B.

Located in the Village of Stanley, on approximately 2.49 ha.,(6.15 ac.), the property contains the former Stanley Health Cen-tre, with a ground floor area of approximately 331 sq. m., (3,566sq. ft.), as well as the former Nashwaak Villa, containing aground floor area of approximately 1,413 sq. m., (15,208sq. ft.). PID 01524859, 01525120 & 75261321. For inspection,contact the Department of Transportation and Infrastructure at506-476-2417.

Property Value: $150,000Closing Date: June 06, 2016

For tender submission criteria,Visit: www.gnb.ca/2221

Call: 506-453-2221E-mail: [email protected]

Reference: Tender No. 17-L0023

Hon. Roger MelansonMinister of Transportation and Infrastructure

Department of Post-Secondary Education,

Training and Labour

Department of Transportationand Infrastructure

Page 20: The Royal Gazette / Gazette royale (16/05/25) · Bathurst, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se termi-nant le 15 septembre 2017. 6. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des

The Royal Gazette — May 25, 2016 648 Gazette royale — 25 mai 2016

AVIS DE RÈGLEL’établissement des modifications à la :

• Norme multilatérale 62-104 sur les offres publiquesd’achat et de rachat

• l’Instruction générale canadienne 62-203 relative auxoffres publiques d’achat et de rachat et

• Modifications corrélatives(ensemble, les modifications).

Consentement ministérielLe 9 mai 2016, le ministre de la Justice a donné son consente-ment à l’établissement des modifications énoncées ci-dessus.

Résumé des modificationsLa modification du régime des OPA améliorera la qualité etl’intégrité de ce régime et rééquilibrera la dynamique actuelleentre l’initiateur, le conseil d’administration de l’émetteur viséet les porteurs de l’émetteur visé des façons suivantes : i) en per-mettant aux porteurs de l’émetteur visé de prendre des décisionsvolontaires, éclairées et coordonnées concernant le dépôt deleurs titres et ii) en accordant au conseil de l’émetteur visé plusde temps et de latitude pour répondre à une OPA.

Date d’entrée en vigueurLes modifications sont entrées en vigueur au Nouveau-Brunswick le 9 mai 2016.

Comment obtenir un exemplaireOn trouvera le texte des modifications énoncées ci-dessus parl’entremise du site web de la Commission : http://www.fcnb.ca

On peut se procurer un exemplaire sur papier du document encommuniquant par courrier, par téléphone ou par courriel avecla Commission, dont voici les coordonnées :

SecrétaireCommission des services financiers et des services aux consommateurs85, rue Charlotte, bureau 300Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2Téléphone : 506-658-3060Sans frais : 1-866-933-2222 (au N.-B. seulement)Télécopieur : 506-658-3059Courriel : [email protected]

________________

Commission des services financiers et des services

aux consommateurs

NOTICE OF RULEThe making of amendments to:

• Multilateral Instrument 62-104 Take-Over Bids and Is-suer Bids

• National Policy 62-203 Take-Over Bids and Issuer Bidsand

• Consequential Amendments(together, the amendments).

Ministerial ConsentOn 9 May 2016, the Minister of Justice consented to the makingof the above-noted amendments.

Summary of AmendmentsThe Bid Amendments will enhance the quality and integrity ofthe take-over bid regime and rebalance the current dynamicsamong offerors, offeree issuer boards of directors, and offereeissuer security holders by (i) facilitating the ability of offereeissuer security holders to make voluntary, informed and co-ordinated tender decisions, and (ii) providing the offeree boardwith additional time and discretion when responding to a take-over bid.

Effective DateThe amendments came into force in New Brunswick on 9 May2016.

How to Obtain a CopyThe text of the above-noted amendments can be obtained fromthe Commission’s website: http://www.fcnb.ca

Paper copies may be obtained from the Commission by writing,telephoning or e-mailing:

SecretaryFinancial and Consumer Services Commission85 Charlotte Street, Suite 300Saint John, N.B. E2L 2J2Telephone: 506-658-3060Toll Free: 866-933-2222 (within NB only)Fax: 506-658-3059E-mail: [email protected]

________________

Financial and Consumer Services Commission

Page 21: The Royal Gazette / Gazette royale (16/05/25) · Bathurst, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se termi-nant le 15 septembre 2017. 6. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des

The Royal Gazette — May 25, 2016 649 Gazette royale — 25 mai 2016

AVIS DE RÈGLEL’établissement des modifications à la :

• Norme multilatérale 62-104 sur les offres publiquesd’achat et de rachat

• Norme canadienne 62-103 sur le système d’alerte et ques-tions connexes touchant les offres publiques et les décla-rations d’initiés et

• l’Instruction générale canadienne 62-203 relative auxoffres publiques d’achat et de rachat

(ensemble, les modifications).

Consentement ministérielLe 9 mai 2016, le ministre de la Justice a donné son consente-ment à l’établissement des modifications énoncées ci-dessus.

Résumé des modificationsLes modifications accroîtront la transparence des participationsimportantes dans les émetteurs assujettis selon le systèmed’alerte. Elles visent à améliorer la qualité et l’intégrité du sys-tème d’alerte d’une façon adéquate pour les marchés financierspublics canadiens.Les modifications préciseront également l’application actuelledes obligations de déclaration selon le système d’alerte à cer-tains types de dérivés et aux mécanismes de prêt de titres.

Date d’entrée en vigueurLes modifications sont entrées en vigueur au Nouveau-Brunswick le 9 mai 2016.

Comment obtenir un exemplaireOn trouvera le texte des modifications énoncées ci-dessus parl’entremise du site web de la Commission : http://www.fcnb.ca

On peut se procurer un exemplaire sur papier du document encommuniquant par courrier, par téléphone ou par courriel avecla Commission, dont voici les coordonnées :

SecrétaireCommission des services financiers et des services aux consommateurs85, rue Charlotte, bureau 300Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2Téléphone : 506-658-3060Sans frais : 1-866-933-2222 (au N.-B. seulement)Télécopieur : 506-658-3059Courriel : [email protected]

________________

Sachez, en vertu du paragraphe 214(2) de la Loi sur les compa-gnies de prêt et de fiducie, chapitre L-11.2, que le surintendanta délivré un premier permis à TMX Equity Transfer and TrustCompany/Société de fiducie et de transfert de valeurs TMX endate du 2 mai 2016.

Le surintendant des compagnies de prêt et de fiducieEtienne LeBoeuf, CPA, CA

NOTICE OF RULEThe making of amendments to:

• Multilateral Instrument 62-104 Take-Over Bids and Is-suer Bids

• National Instrument 62-103 The Early Warning Systemand Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issuesand

• Changes to National Policy 62-203 Take-Over Bids andIssuer Bids

(together, the amendments).

Ministerial ConsentOn 9 May 2016, the Minister of Justice consented to the makingof the above-noted amendments.

Summary of AmendmentsThe amendments will provide greater transparency about sig-nificant holdings of reporting issuers’ securities under the earlywarning system. They are intended to enhance the quality andintegrity of the early warning system in a manner that is suitablefor the Canadian public capital markets.The amendments will also clarify the current application ofearly warning reporting requirements to certain derivative ar-rangements and to securities lending arrangements.

Effective DateThe amendments came into force in New Brunswick on 9 May2016.

How to Obtain a CopyThe text of the above-noted amendments can be obtained fromthe Commission’s website: http://www.fcnb.ca

Paper copies may be obtained from the Commission by writing,telephoning or e-mailing:

SecretaryFinancial and Consumer Services Commission85 Charlotte Street, Suite 300Saint John, N.B. E2L 2J2Telephone: 506-658-3060Toll Free: 866-933-2222 (within NB only)Fax: 506-658-3059E-mail: [email protected]

________________

Public notice is hereby given pursuant to subsection 214(2) ofthe Loan and Trust Companies Act, chapter L-11.2, that the Su-perintendant has issued a first licence to TMX Equity Transferand Trust Company/Société de fiducie et de transfert de valeursTMX effective 2 May 2016.

Etienne LeBoeuf, CPA, CASuperintendent of Loan and Trust Companies

Page 22: The Royal Gazette / Gazette royale (16/05/25) · Bathurst, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se termi-nant le 15 septembre 2017. 6. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des

The Royal Gazette — May 25, 2016 650 Gazette royale — 25 mai 2016

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Ronald Giouard, Joseph Ernest Girouard, Ronald Girouardoriginal Mortgagors and owner of the equity of redemption; andto all others whom it may concern. Sale pursuant to terms of themortgage and the Property Act, R.S.N.B. 1973, c.P-19, asamended. Freehold property situated at 816 Route 11, BartibogBridge, in the County of Northumberland and Province of NewBrunswick, and being identified as PID 40046815.

Notice of Sale given by The Toronto-Dominion Bank, Mort-gagee and holder of the mortgage. Sale to be held at theMiramichi Court House, 673 King George Highway,Miramichi, New Brunswick on Thursday, June 9, 2016, at thehour of 11:00 a.m., local time. See advertisement of Notice ofMortgage Sale in the Miramichi Leader dated May 4, May 11,May 18, and May 25, 2016.

McInnes Cooper, Solicitors for The Toronto-Dominion Bank,Per: Sarah R. Reardon, Suite 1700, Brunswick Square, 1 GermainStreet, P.O. Box 6370, Saint John, New Brunswick, E2L 4R8,Telephone: 506-643-6500, Facsimile: 506-643-6505

________________

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Mary Gail Martin original Mortgagor and owner of the eq-uity of redemption; Joseph Eric Martin, Spouse of the originalMortgagor; and to all others whom it may concern. Sale pursu-ant to terms of the mortgage and the Property Act, R.S.N.B.1973, c.P-19, as amended. Freehold property situated at 5289Route 117, Baie-Sainte-Anne, in the County of Northumber-land and Province of New Brunswick, and being identified asPID 40432007.

Notice of Sale given by The Toronto-Dominion Bank, Mort-gagee and holder of the mortgage. Sale to be held at theMiramichi Court House, 673 King George Highway,Miramichi, New Brunswick on Thursday, June 9, 2016, at thehour of 11:15 a.m., local time. See advertisement of Notice ofMortgage Sale in the Miramichi Leader dated May 4, May 11,May 18, and May 25, 2016.

McInnes Cooper, Solicitors for The Toronto-Dominion Bank,Per: Sarah R. Reardon, Suite 1700, Brunswick Square, 1 GermainStreet, P.O. Box 6370, Saint John, New Brunswick, E2L 4R8,Telephone: 506-643-6500, Facsimile: 506-643-6505

________________

Notices of Sale

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)

Destinataires : Ronald Giouard, Joseph Ernest Girouard,Ronald Girouard, débiteurs hypothécaires originaires et pro-priétaires du droit de rachat; et tout autre intéressé éventuel.Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypo-thèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973,c.P-19. Biens en tenure libre situés au 816, route 11, à BartibogBridge, comté de Northumberland, province du Nouveau-Brunswick, et dont le NID est 40046815.Avis de vente donné par la Banque Toronto-Dominion, créan-cière hypothécaire et titulaire de l’hypothèque. La vente auralieu le jeudi 9 juin 2016, à 11 h, heure locale, au palais de justicede Miramichi, 673, route King George, Miramichi (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des4, 11,18 et 25 mai 2016 du Miramichi Leader.

Sarah R. Reardon, du cabinet McInnes Cooper, avocats de laBanque Toronto-Dominion, Brunswick Square, 1, rue Germain,bureau 1700, C.P. 6370, Saint John (Nouveau-Brunswick)E2L 4R8; téléphone : 506-643-6500; télécopieur : 506-643-6505

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)

Destinataires : Mary Gail Martin, débitrice hypothécaire origi-naire et propriétaire du droit de rachat; Joseph Eric Martin,conjoint de la débitrice hypothécaire originaire; et tout autre in-téressé éventuel. Vente effectuée en vertu des dispositions del’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens,L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au5289, route 117, à Baie-Sainte-Anne, comté de Northumber-land, province du Nouveau-Brunswick, et dont le NID est40432007.Avis de vente donné par la Banque Toronto-Dominion, créan-cière hypothécaire et titulaire de l’hypothèque. La vente auralieu le jeudi 9 juin 2016, à 11 h 15, heure locale, au palais dejustice de Miramichi, 673, route King George, Miramichi(Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditionsdes 4, 11, 18 et 25 mai 2016 du Miramichi Leader.

Sarah R. Reardon, du cabinet McInnes Cooper, avocats de laBanque Toronto-Dominion, Brunswick Square, 1, rue Germain,bureau 1700, C.P. 6370, Saint John (Nouveau-Brunswick)E2L 4R8; téléphone : 506-643-6500; télécopieur : 506-643-6505

________________

Avis de vente

Page 23: The Royal Gazette / Gazette royale (16/05/25) · Bathurst, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se termi-nant le 15 septembre 2017. 6. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des

The Royal Gazette — May 25, 2016 651 Gazette royale — 25 mai 2016

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: The Estate of Ersel Wilfrid Fox, original Mortgagor andowner of the equity of redemption; and to Carrie Fox, spouse ofthe original Mortgagor; and to all others whom it may concern.Sale pursuant to terms of the mortgage and the Property Act,R.S.N.B. 1973, c.P-19, as amended. Freehold property situatedat 25 O’Connell Avenue, Sussex, in the County of Kings andProvince of New Brunswick, and being identified as PID30216071.Notice of Sale given by The Toronto-Dominion Bank, Mort-gagee and holder of the mortgage. Sale to be held at the SaintJohn Law Courts, Saint John, New Brunswick on Thursday,June 2, 2016, at the hour of 11:00 a.m., local time. See adver-tisement of Notice of Mortgage Sale in the Telegraph-Journaldated May 4, May 11, May 18, and May 25, 2016.

McInnes Cooper, Solicitors for The Toronto-Dominion Bank,Per: Natalie Stewart, Suite 1700, Brunswick Square, 1 GermainStreet, P.O. Box 6370, Saint John, New Brunswick, E2L 4R8,Telephone: 506-643-6500, Facsimile: 506-643-6505

________________

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Maria Jorge Leite-Olivier, original Mortgagor; and to allothers whom it may concern. Sale pursuant to terms of theMortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Actsin amendment thereof. Freehold property being situated at 469Gondola Point Road, Quispamsis, New Brunswick, the same lotconveyed to Maria Jorge Leite-Olivier by Transfer registered inthe Land Titles System on September 9, 2008, as documentnumber 26124033.

Notice of Sale given by The Bank of Nova Scotia as Mortgagee.Sale to be held at the Saint John Provincial Building located at10 Peel Plaza, Saint John, New Brunswick on the 9th day ofJune, 2016, at the hour of 11:00 a.m., local time. See advertise-ment of Notice of Sale in the Telegraph-Journal dated May 12,May 19, May 26 and June 2, 2016.

McInnes Cooper, Solicitors for The Bank of Nova Scotia, Per:Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400,P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Tele-phone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095

The Royal Gazette is published every Wednesday under theauthority of the Queen’s Printer Act. Documents must be re-ceived by the Royal Gazette Coordinator, LegislativeServices, no later than noon, at least seven days prior toWednesday’s publication. Each document must be separatefrom the covering letter. Signatures on documents must be im-

Notice to Advertisers

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)

Destinataires : La succession d’Ersel Wilfrid Fox, débiteur hy-pothécaire originaire et propriétaire du droit de rachat; CarrieFox, conjointe du débiteur hypothécaire originaire; et tout autreintéressé éventuel. Vente effectuée en vertu des dispositions del’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens,L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au 25, ave-nue O’Connell, à Sussex, comté de Kings, province duNouveau-Brunswick, et dont le NID est 30216071.Avis de vente donné par la Banque Toronto-Dominion, créan-cière hypothécaire et titulaire de l’hypothèque. La vente auralieu le jeudi 2 juin 2016, à 11 h, heure locale, au palais de justicede Saint John, Saint John (Nouveau-Brunswick). Voir l’an-nonce publiée dans les éditions des 4, 11, 18 et 25 mai 2016 duTelegraph-Journal.

Natalie Stewart, du cabinet McInnes Cooper, avocats de laBanque Toronto-Dominion, Brunswick Square, 1, rue Germain,bureau 1700, C.P. 6370, Saint John (Nouveau-Brunswick)E2L 4R8; téléphone : 506-643-6500; télécopieur : 506-643-6505

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)

Destinataires : Maria Jorge Leite-Olivier, débitrice hypothé-caire originaire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuéeen vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles dela Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenurelibre situés au 469, chemin Gondola Point, à Quispamsis, auNouveau-Brunswick, et correspondant au même lot ayant ététransféré à Maria Jorge Leite-Olivier par l’acte de transfert en-registré dans le système d’enregistrement foncier le 9 sep-tembre 2008, sous le numéro 26124033.Avis de vente donné par la Banque de Nouvelle-Écosse, créan-cière hypothécaire. La vente aura lieu le 9 juin 2016, à 11 h,heure locale, à l’édifice provincial de Saint John, 10, place Peel,Saint John (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dansles éditions des 12, 19 et 26 mai et du 2 juin 2016 du Telegraph-Journal.

Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banquede Nouvelle-Écosse, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Main, bu-reau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6;téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformé-ment à la Loi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents àpublier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazetteroyale, aux Services législatifs, à midi, au moins sept joursavant le mercredi de publication. Chaque avis doit être séparéde la lettre d’envoi. Les noms des signataires doivent suivre

Avis aux annonceurs

Page 24: The Royal Gazette / Gazette royale (16/05/25) · Bathurst, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se termi-nant le 15 septembre 2017. 6. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des

The Royal Gazette — May 25, 2016 652 Gazette royale — 25 mai 2016

mediately followed by the printed name. The Royal GazetteCoordinator may refuse to publish a document if any part of itis illegible, and may delay publication of any document for ad-ministrative reasons.Prepayment is required for the publication of all documents.Standard documents have the following set fees:

Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque ormoney order (payable to the Minister of Finance). No refundswill be issued for cancellations.

The official version of The Royal Gazette is available freeon-line each Wednesday. This free on-line service replaces theprinted annual subscription service. The Royal Gazette can beaccessed on-line at:

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/attorney_general/royal_gazette.html

NoticesCost perInsertion

Notice of the intention to apply for the enactment of a private bill

$ 20

Originating process $ 25Order of a court $ 25Notice under the Absconding Debtors Act $ 20Notice under the General Rules under the Law Society Act,

1996, of disbarment or suspension or of application forreinstatement or readmission

$ 20

Notice of examination under the Licensed Practical NursesAct

$ 25

Notice under the Motor Carrier Act $ 30Any document under the Political Process Financing Act $ 20

Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9under the Probate Court Act

$ 20

Notice under Rule 70 of the Rules of CourtNote: Survey Maps cannot exceed 8.5″ x 14″

$120

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is1/2 page in length or less

$ 20

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice isgreater than 1/2 page in length

$ 75

Any document under the Winding-up and Restructuring Act(Canada)

$ 20

Notice of a correction charge isthe same as

for publishing the original document

Any other document $3.50 for each cm or less

immédiatement la signature. La coordonnatrice de la Gazetteroyale peut refuser de publier un avis dont une partie est illi-sible et retarder la publication d’un avis pour des raisons ad-ministratives.Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis.Voici les tarifs pour les avis courants :

Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte decrédit MasterCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (àl’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement nesera effectué en cas d’annulation.

La version officielle de la Gazette royale est disponible gra-tuitement et en ligne chaque mercredi. Ce service gratuit enligne remplace le service d’abonnement annuel. Vous trouve-rez la Gazette royale à l’adresse suivante :

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/procureur_general/gazette_royale.html

AvisCoût par parution

Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loid’intérêt privé

20 $

Acte introductif d’instance 25 $Ordonnance rendue par une cour 25 $Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite 20 $Avis de radiation ou de suspension ou de demande de

réintégration ou de réadmission, exigé par les Règlesgénérales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur leBarreau

20 $

Avis d’examen exigé par la Loi sur les infirmières etinfirmiers auxiliaires autorisés

25 $

Avis exigé par la Loi sur les transports routiers 30 $Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur le

financement de l’activité politique20 $

Avis aux créanciers exigé par le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour dessuccessions

20 $

Avis exigé par la Règle 70 des Règles de procédureNota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 po

sur 14 po

120 $

Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est d’une demi-page ou moins enlongueur

20 $

Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est de plus d’une demi-page enlongueur

75 $

Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur lesliquidations et les restructurations (Canada)

20 $

Avis d’une correction les frais sont les mêmes que ceux imposés

pour la publication du

document original

Tout autre document 3,50 $ pour chaque cm ou

moins

Page 25: The Royal Gazette / Gazette royale (16/05/25) · Bathurst, à compter du 7 avril 2016, pour un mandat se termi-nant le 15 septembre 2017. 6. En vertu de l’alinéa 4(1)a) et des

The Royal Gazette — May 25, 2016 653 Gazette royale — 25 mai 2016

Print-on-demand copies of The Royal Gazette are available, atthe following address, at $4.00 per copy plus 5% tax, plusshipping and handling where applicable.

Legislative ServicesOffice of the Attorney General

Chancery Place675 King StreetP.O. Box 6000

Fredericton, NB E3B 5H1

Tel: 506-453-8372E-mail: [email protected]

Note: Deliveries are to be addressed to The Royal Gazette andleft with the Commissionaire.

Nous offrons, sur demande, des exemplaires de la Gazetteroyale, à l’adresse suivante, pour la somme de 4 $ l’exem-plaire, plus la taxe de 5 %, ainsi que les frais applicables deport et de manutention.

Services législatifsCabinet du procureur général

Place Chancery675, rue King

C.P. 6000Fredericton (N.-B.) E3B 5H1

Tél. : 506-453-8372Courriel : [email protected]

Note : Toute livraison étant adressée à la Gazette royale doitêtre remise au commissionnaire.

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

All rights reserved / Tous droits réservés