the royal gazette / gazette royale (17/02/15) · the royal gazette — february 15, 2017 180...

32
The Royal Gazette Fredericton New Brunswick Gazette royale Fredericton Nouveau-Brunswick Vol. 175 Wednesday, February 15, 2017 / Le mercredi 15 février 2017 179 ISSN 1714-9428 Notice to Readers The Royal Gazette is officially published on-line. Except for formatting, documents are published in The Royal Gazette as submitted. Material submitted for publication must be received by the Royal Gazette coordinator no later than noon, at least 7 working days prior to Wednesday’s publication. However, when there is a public holiday, please contact the coordinator. JANUARY 18, 2017 2017-13 Under paragraph 8(1)(a.1) and subsection 9(2) of the Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers’ Compensation Appeals Tribunal Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints Haley Flaro, Fredericton, New Brunswick, as Vice-Chair of the Workplace Health, Safety and Compensa- tion Commission, effective January 18, 2017, for a term of four years. Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor ________________ Orders in Council Avis aux lecteurs La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne. Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans la Gazette royale comme soumis. Les documents à publier doivent parvenir au coordonna- teur de la Gazette royale, à midi, au moins 7 jours ou- vrables avant le mercredi de publication. En cas de jour férié, veuillez communiquer avec le coordonnateur. LE 18 JANVIER 2017 2017-13 En vertu de l’alinéa 81)a.1) et du paragraphe 9(2) de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents du tra- vail, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Haley Flaro, de Fredericton (Nouveau-Brunswick), vice-présidente de la Com- mission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des ac- cidents au travail, pour un mandat de quatre ans, à compter du 18 janvier 2017. La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau ________________ Décrets en conseil

Upload: others

Post on 13-Jul-2020

18 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The RoyalGazette

FrederictonNew Brunswick

Gazetteroyale

FrederictonNouveau-Brunswick

Vol. 175 Wednesday, February 15, 2017 / Le mercredi 15 février 2017 179

ISSN 1714-9428

Notice to Readers

The Royal Gazette is officially published on-line.

Except for formatting, documents are published in TheRoyal Gazette as submitted.

Material submitted for publication must be received bythe Royal Gazette coordinator no later than noon, at least7 working days prior to Wednesday’s publication.However, when there is a public holiday, please contactthe coordinator.

JANUARY 18, 20172017-13

Under paragraph 8(1)(a.1) and subsection 9(2) of the WorkplaceHealth, Safety and Compensation Commission and Workers’Compensation Appeals Tribunal Act, the Lieutenant-Governorin Council appoints Haley Flaro, Fredericton, New Brunswick,as Vice-Chair of the Workplace Health, Safety and Compensa-tion Commission, effective January 18, 2017, for a term of fouryears.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor

________________

Orders in Council

Avis aux lecteurs

La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne.

Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dansla Gazette royale comme soumis.

Les documents à publier doivent parvenir au coordonna-teur de la Gazette royale, à midi, au moins 7 jours ou-vrables avant le mercredi de publication. En cas de jourférié, veuillez communiquer avec le coordonnateur.

LE 18 JANVIER 20172017-13

En vertu de l’alinéa 81)a.1) et du paragraphe 9(2) de la Loi sur laCommission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation desaccidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents du tra-vail, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Haley Flaro, deFredericton (Nouveau-Brunswick), vice-présidente de la Com-mission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des ac-cidents au travail, pour un mandat de quatre ans, à compter du18 janvier 2017.

La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

________________

Décrets en conseil

Page 2: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017

JANUARY 18, 20172017-14

Under subparagraph 6(2)(b)(iii) and subsection 6(5) of the Bea-verbrook Art Gallery Act, the Lieutenant-Governor in Councilappoints Thierry Arseneau, Fredericton, New Brunswick, as amember of the Board of Governors of the Beaverbrook Art Gal-lery, effective January 18, 2017, for a term of three years.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor

LE 18 JANVIER 20172017-14

En vertu du sous-alinéa 6(2)b)(iii) et du paragraphe 6(5) de laLoi sur la Galerie d’art Beaverbrook, le lieutenant-gouverneuren conseil nomme Thierry Arseneau, de Fredericton (Nouveau-Brunswick), membre du conseil d’administration de la Galeried’art Beaverbrook, pour un mandat de trois ans, à compter du18 janvier 2017.

La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

030160 030160 N.B. Ltd.031706 031706 N. B. LTD.037042 037042 N.B. LTD.041441 041441 N. B. Ltd.043830 043830 N.-B. LIMITEE049373 049373 N.-B. LTEE059477 059477 N.-B. INC.059739 059739 N.B. Ltd.059744 059744 N.B. LTD.681527 21st Century Natural Approach Ltd.501733 501733 N.B. LTD.503510 503510 N.B. LTD.506505 506505 N.B. INC.506653 506653 NB Ltd.643908 507311 NB Ltd.508810 508810 NB Inc.509018 509018 NB INC.511426 511426 N.B. INC.511532 511532 N.B. INC.511563 511563 N.B. LTD.513996 513996 N.B. Ltd.514004 514004 N. B. Ltd.514046 514046 N.B. LTD.514201 514201 N.B. LTD.605789 605789 N.B. Inc.611232 611232 New Brunswick Limited617976 617976 N.B. Ltd.624454 624454 NB INC.624478 624478 N.B. Ltd.630689 630689 NB INC.630911 630911 NB INC.637164 637164 N.B. INC.637294 637294 N.B. Inc.637360 637360 NB INC.637363 637363 N.B. Inc.643329 643329 N.B. Inc.643501 643501 N.B. Inc.643562 643562 NEW BRUNSWICK INC.643648 643648 NB Inc.643672 643672 NB Inc.

649681 649681 N.B. Inc.649719 649719 N.B. Inc.649812 649812 N.B. Inc.649839 649839 N.B. LTD.650003 650003 NB LTD. 650003 NB LTEE650100 650100 N.B. Ltd.650139 650139 N.B. Inc.650200 650200 N.B. LTD.656160 656160 N.B. Ltd.656248 656248 N.B. Inc.656509 656509 NB Inc.656532 656532 N.B. Ltd.656559 656559 N.B. LTD.656586 656586 N.B. INC. 656586 N.-B. INC.662524 662524 N.B. LTD.662565 662565 N.B. LTD.662677 662677 N.B. Inc.662712 662712 New Brunswick Ltd.662832 662832 NB INC.662854 662854 N.B. INC.662857 662857 NB INC.669104 669104 NB INC.669105 669105 NB LTD.669175 669175 NB Ltd.669242 669242 N.B. Inc.669294 669294 N.B. Ltd.669315 669315 NB Inc.669498 669498 NB Ltd.669501 669501 N.B. Inc.669505 669505 NB Ltd.- 669505 NB Ltée675437 675437 NB Inc.675452 675452 NB LTD.675636 675636 N.B. Inc.675654 675654 N.B. Inc.675656 675656 N.B. Inc.675657 675657 N.B. Inc.675708 675708 N.B. Inc.675734 675734 NB INC.675777 675777 NB Inc.681261 681261 NB Ltd.

681294 681294 (N.B.) Inc.681307 681307 (N.B.) Inc.681360 681360 NB Ltée681365 681365 N.B. Ltd.681432 681432 NB INC.681448 681448 N.B. Inc.681494 681494 NB Inc.681507 681507 NB Ltd.681524 681524 NB Inc.681575 681575 NB INC.681578 681578 N.B. Inc.681596 681596 NB Inc.681597 681597 NB Inc.681598 681598 NB Inc.681638 681638 N.B. Inc.681658 681658 NB LTD.681686 681686 NB INC.681707 681707 N.B. Ltd.681750 681750 NB Ltd.681777 681777 N.B. Ltd.000070 A & F ENTERPRISES LTD.656598 A & J Hill Holdings Inc.617641 A Lot of Auto Recyclers Inc.008221 A. R. HOWATT & SON LTD.047019 A.C. MCDONALD FOUNDATION &

BUILDING MOVERS INC.617911 ABC GESTION ZENITH LTEE/ABC

ZENITH MANAGEMENT LTD.636995 Abiron Enterprises Ltd.656424 Acadia Marble, Tile & Terrazzo Ltd.000086 AHE PLUMBING & HEATING LTD.637271 Albert County Mechanical Ltd643427 ALL SEA ATLANTIC LTD.669289 Allison Creek Wines Inc.637184 ALREADY RITCHIE PROPERTIES

LTD.669299 AMJP Real Estate NB Inc.047016 AQUILA TECHNOLOGIES INC.681293 Ashlyn Contracting Enterprises Ltd.675672 Atlantic Capital Holdings Inc.

Avis d’une décision de dissoudre les corporations provincialeset d’annuler l’enregistrement des corporations extraprovin-ciales

Avis d’une décision de dissoudre les corporations provincialesSachez que le directeur, en application de la Loi sur les corporationscommerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations sui-vantes en vertu de l’alinéa 139(1)c) de la Loi, puisque lesdites corpo-rations ont fait défaut de faire parvenir au directeur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la datede la publication du présent avis dans la Gazette royale, le directeurpourra dissoudre lesdites corporations.

Loi sur les corporationscommerciales

Notice of a decision to dissolve provincial corporations and tocancel the registration of extra-provincial corporations

Notice of decision to dissolve provincial corporationsTake notice that the Director under the Business Corporations Act hasmade a decision to dissolve the following corporations pursuant toparagraph 139(1)(c) of the Act, as the said corporations have been indefault in sending to the Director fees, notices, and/or documents re-quired by the Act. Please note that 60 days after the date of publicationof this Notice in The Royal Gazette, the Director may dissolve thecorporations.

Business Corporations Act

Page 3: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 181 Gazette royale — 15 février 2017

643830 Atlantic Fleet Maintenance Inc.511510 ATLANTIC FORESTRY SERVICES

LTD.637330 ATLANTIC POST AND BEAM

CONSTRUCTION LTD.516352 ATLANTIC ZINC EXPLORATION

INC.643736 B2 North Group Inc.643805 BART GORMAN ENTERPRISES LTD.001613 BAYSIDE STEVEDORING LTD.643355 BEAULIEU HYDRAULIQUE INC.506598 BENCHMARK GIFTS LTD.617904 BETCO HAULAGE LTD.001854 BETON BRUNSWICK LTEE643133 BEYEA ENTERPRISES LTD.669506 Bistro La Brôkerie Inc.643832 BizCom Inc.504321 BLEUETIERE A.J.M. INC.681529 BnR General Contracting Ltd.669006 Bootic Canada Inc.514094 BOUR-Q AGENCIES LTD.675463 Bret Folkins Services Inc.637195 BROOKS HOMES LTD.630933 BRYCO FASTENERS LTD.650053 Burns Manor Inc.044166 CANADA IRON CASTINGS LTD.624103 CANI TRUCKING INC.630619 CAPITAL CITY ROOFING (2007) LTD.044500 CARCROFT HOLDINGS INC.656455 CAROLYNE WILBUR MOTORS INC.681595 Casedepot Ltd.511627 CASEY HOLDINGS INC.014217 CENTENNIAL LEASEHOLDS

LIMITED511386 CENTRE DE REMBOURSEMENT

LAMÈQUE INC.649768 Centrosolar Canada Inc.031645 CHAMCOOK ASSOCIATES LTD.630510 CHATEAU SALISBURY INC.501800 CHIASSON AQUACULTURE LTEE681437 Chipper Consulting Inc.681487 CINEFREQ INC.504422 CLC TRAILER RENTALS LTD.681584 ClemTech Inc.650193 Cleveland Holdings Inc675433 CloudRange Inc.003818 CLOVER CONSTRUCTION LTD.003950 COATES AND HAINES LTD.630633 Colonial Inn Saint John Inc.031596 COLPITTS SERVICE CENTRE LTD.669351 Communikel Inc.669115 County Line Trucking Ltd.656338 CPC Tri County Taxi Inc.656487 Creative Sign Service Ltd.681602 CREW CAB AUTO SALES LTD.039119 CRIMAC INC.501869 D & P CONTRACTORS LTD.506589 D.W. AUTO & SALVAGE LTD.039124 DALHOUSIE STOP FLAME LTD.611426 Delaney & Coyle Volks Inc.605626 Delphinium Ltée675446 DENTAL DEVELOPMENT

INTERNATIONAL INC.502024 DEPANNEUR CHEZ RACHEL LTEE681629 DEVAFFAIR INNOVATIVE

THINKING INC.650212 DEVOST REFRIGERATION (2010)

INC.617629 Direct Mortgage Inc.681428 Diversified Electrical Inc.005093 DOIRON ET FRERES LTEE669490 Dominique M. Harvey Professional

Corporation681285 Dr. Ahmad Sawwan P.C. Inc.649688 Dr. Audra Gedmintas Professional

Corporation637353 DR. DUNCAN WEBSTER

PROFESSIONAL CORPORATION643828 Dr. German W. Blando cp inc.

630669 Dr. J. J. Morales Professional Corporation514135 DR. RONALD HAREBOTTLE PROF.

CORP.600171 DR. TIFFANY KEENAN

PROFESSIONAL CORPORATION617743 E. D. McNally Holdings Limited681763 E.M.R. MARKETING CORP.600284 EasiView Home Surveillance Inc.005533 EASTERN OFFICE SHOP LTD.656553 Ebates Canada, Inc.059791 EDDIES PLUMBING & HEATING

LTD.681215 ELUMICATE INC.656709 Elva Corporation Ltd.650109 Ernest Légère Holdings Inc.656739 EURO MOTORCYCLES LTD.035099 EVERETT’S HEATING LTD.681782 EXPERIENTIAL DEA INC.006040 F. & G. MANAGEMENT LIMITEE514120 Financial Fitness Inc.006280 FLETT MOTORS LIMITED650208 FLM LOANS CANADA LTD.656497 FMR Inspection Ltd.681545 Folk Media Communications Inc.681430 FONDS RÉGIONALE

D’INVESTISSEMENT KEDGWICK INC.

624269 Forton Properties Limited650057 FOULEM LOGEMENTS LTÉE004389 FRED’S HOLDINGS LTD.031571 FULL CIRCLE ENTERPRISES LTD.611279 G & C FOUNDATION LTD.630944 G.C. Auto Wreckers Inc.011030 Gaddess Industrial Inc.650168 GATEWAY YOUTH SERVICES LTD.681778 GC Cook In Services Inc.681734 Generation Five Fisheries Inc.669466 Gestion Frenette et Poitras Inc.046967 GIL PELLETIER TRUCKING LTD.649937 Gino LeBlanc Professional Corporation662507 Glen Elm Farms Inc.656339 GM BEAULIEU PROPERTIES INC.681567 Gordon Cunningham Electrical Ltd.600343 GORDON PLAZA LTD.630656 Gordon Sharpe Enterprises Inc.662552 Gorge Investments Inc.051680 GRAND LAKE SILVICULTURE LTD.643422 Greg Hanlon Holdings Ltd.662666 Ground Worx Equipment Rentals Ltd.662536 Grove Offroad (2012) Ltd.662891 Guillaume Basque Consultant Ltd.681678 Guy R. Day & Son Limited007616 H B D ENTERPRISES LTD.605794 H B M INVESTMENTS LTD.669097 Hammond Industries Export and

Development Ltd.643395 Handley House Ltd.041603 HARMONY HOMES LTD.617875 HATHSOME Enterprises Inc.649630 HFHG Consulting Inc.605760 HILLCREST NURSERIES AND

GREENHOUSES INC.031608 HORIZON ENTERPRISES LTD.617447 Howard Brook Development Inc.044137 I.C.R. SALES & SERVICE LTD.630720 Inevitable Holdings Corp.649844 INFORMATICS TERAFLOP

CENTRAL INC.631002 Ingallwood Manufacturing Inc617673 Innoseal Canada Ltd.643675 INNOVATION GATEWAY NORTH

AMERICA INC.681742 Insight Health Plus Wellness Inc.008540 INVESTMENT SECURITIES LIMITED675700 Irishtown Self Storage Inc.649615 J & L ENERGY INC.008602 J. C. SIDING PRODUCTS LIMITED669177 J.R. Boulay Mining Incorporated656723 JDR Demolition NB Inc.

681784 JenKal Training & Professional Development Inc.

662841 JETIX SOLUTIONS LTD.611646 John D. Boyd Plumbing & Heating Ltd.681747 JR Logging Ltd.681336 K & C Logging Ltd.681311 K.S.CAREssentials Inc.056345 KASNER’S LIMITED643371 Kasper Ventures NB Ltd.643813 KGC Building Supplies Ltd.051681 KMA HOLDINGS INC.681334 KNG Harvesting Inc.669419 KTH Restaurant Consulting and Services

Inc.047115 KTK HATFIELD INVESTMENTS INC.656252 L&L BoatTransportation Ltd.681509 L’arbre de l’amitié Ltee044182 LAMEQUE QUALITY GROUP LTD./

GROUPE QUALITE LAMEQUE LTEE

009669 LAWCO LTD.624707 LBD-BBD Enterprises Limited681318 LEBLANC SCOTT CPA

PROFESSIONAL CORPORATION662695 Leferg Forming and Construction Ltd.041359 LES ENTREPRISES ROGER ROY

LTEE662868 Les Homardiers de Pigeon Hill inc.008529 LES INVESTISSEMENTS

LEGRESLEY LTEE - LEGRESLEY INVESTMENTS LTD.

013382 LES PRODUCTEURS D’ARBRES DE NOEL CLAIRE-FONTAINE LTEE.

675277 Les productions Vaugo Inc.662474 LIBBY HOLDING INC.656500 LIFT PERSONAL FITNESS INC.516358 Lily Hill Management Ltd.662830 LLMJ Holdings Inc.650065 LOGICAL GLOBAL SOLUTIONS INC.624193 Logroty Inc.511460 LONE PINE TREE CARE LTD.643628 Losier Logistique Ltée056766 LOUMAREX INC.508850 M & W CONTRACTING LTD.010148 M. & B. CLEANERS LIMITED649963 M. J. Roy Foundation NB Inc.669284 M.A.N CONTRACTING LTD.643260 M.R. JAILLET ENTERPRISES INC.637154 MacLeod Agronomics Ltd.605712 MAISONS MELANSON HOMES INC.650209 MakCass Management Inc.656552 Maple Leaf Queen’s Buffet Inc.010443 MARCHE B. PAULIN LTEE010466 MARENCO LTD.036897 MARIETTE ENTREPRISES LTEE681764 Mariflex 2015 Ltd.637322 Maritime Eco Energy Solutions Inc.637118 Maritime Lifts Inc010670 MARSHLAND FARMS LTD.681577 Matt Whittaker’s Trucking Ltd.649940 McAllister Realty Ltd.031707 MCKAY’S DAIRY LTD.675764 Measur3d Geomatics Ltd.046997 MERIDIAN MANAGEMENT INC.662473 MODERN REALTY NB INC.511467 MOE’S ELECTRIC LTD.049342 MONCTON MOTOR INN (1991) LTD.656227 MORETRENCH CANADIAN CORP.681368 Mountain Automation Solutions Inc.637357 Muir Bros. Services Ltd.656569 N.A.C. Express Auto Sales Inc.662623 NIK ENTERPRISES LTD.662515 NORT CENTRAL POSITRONICS LTD.012504 O’BRIEN & LANDRY LIMITED649852 O’KIM INVESTMENTS Inc.514029 OCEAN LEGACY INC.662696 Ogamah Enterprises Ltd.502011 PALLADON HOLDINGS INC.053761 PASSEKEAG PHEASANTS LTD.

Page 4: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 182 Gazette royale — 15 février 2017

511374 Pattison Financial Group Inc.681499 Pêcheries Mainville Inc.012224 PECHERIES STEMALI LIMITEE669298 Peekaboo Amusements Inc.681720 Perkfect Bean Co. Inc.012994 PERRIN’S SALES & SERVICE LTD.681653 PILA INVESTMENTS LTD.681647 Pilotalk Audio Inc.662913 PJ ATLANTIC RESTAURANTS

(FRED-NORTH) LTD.662503 PJ ATLANTIC RESTAURANTS

(SAINT JOHN EAST) LTD.036925 PLACEMENTS A. LAVIGNE LTEE681387 Postech Screw Piles Moncton Inc.675223 Presto Plans Inc.611384 Pub du Quai Inc.656030 QUEEN STREET FRESH MARKET

FOODS LTD.669020 Quillis Nuts & Bolts Inc.662447 R.B. Christie Ventures Inc.605770 R.F. Seafood Consulting & Equipment

Ltd.669202 RDP Bistros Inc.504228 RECYCLAGE PENINSULE LTEE611210 REECE-DYNE INVESTMENTS INC.650084 REMAR HOLDINGS INC.637137 RENTAL (NB) PORTFOLIO INC.051732 REPTILE ZOO -ZOO DE REPTILES

INC.047153 RESIDEX INC.675322 River Country Campground Ltd.501912 RJB COMMUNICATIONS INC.681329 ROJSKOJ Fitness Center & Spa Ltd.624511 Roland’s On The Spot Welding Ltd.681299 RONALD B. MANAGEMENT INC.504319 ROOFCHEK INC.

031683 ROSAIRE DUMOUCHEL INC.014435 RYDER HOMES & TRAILERS LTD.053671 S. & L. REALTY 2000 INC.681481 S.M. Holmes Contracting Ltd.624637 SACKVET CLINIC INC.030213 Sea-Post Ltd.681536 Seaboard Investments Ltd.014910 SEACO LIMITED669434 Segufix Canada Inc.056901 Senada Inc.038973 SERVICES MARITIMES DE BAS-

CARAQUET LTEE681369 Shaman Communications Inc.051630 SILVA CONTRACTORS LTD656673 Silverport Holdings Inc.681424 Sim Construction & Fabrication Ltd.508962 Smartypants.com Inc.637223 Soap-N-Go Ltd.662783 SOCIETE DE GESTION DERIK

FOULEM INC.669200 Society Four Inc.675425 Song’s Good Associates Inc.662890 Southern Cross Seaplants Inc.662582 Space-Time Insight (Canada) Inc.514121 StageCrew INC.053668 SUPERIOR CONCRETE FINISHING

LTD.675568 T.M. Solutions (2014) Inc.669525 T.P. Downey and Sons, Limited511579 T.S. HACHEY & SONS, LIMITED504424 TANYA GAYLE ESTATES LTD.662659 Taymouth Contracting Ltd611453 TBERNARD SOFTWARE Inc.611743 Terry’s Beef “N” More Inc.669485 The Briggs Wealth Management Group

Inc.

669450 TINY EXPLORERS DAYCARE INC.669429 TM Procure Ca Inc.650067 TMF YACHT INC056774 TONY AMUSEMENT LTD.049345 TOTAL PRICING SYSTEMS INC.656450 Traci Price Design Inc.051665 TRACTORS PLUS LTD.662889 True North General Contracting Ltd.675518 TUCKER PARK DEVELOPMENT

CORPORATION681729 Turul Transportation Ltd.501991 ULTRA-POLY MANUFACTURING

INC.630779 UNICONTEX LIMITED662513 United Traders Holding Ltd.662642 Up In Stairs & Finish Inc.056917 VALLEY ELECTRIC LTD.035104 VANCE’S GARAGE LTD.624440 Vanguard Carbon Inc.681506 ventureality.ca inc649633 Verbeek Technical Services Ltd.681425 Vesta Trucking Ltd.669103 Vista Energy Group Ltd.611465 W. R. Burns Construction Ltd.501985 WATERMANIA INC.681402 Wayne’s Auto World 2015 Ltd.611481 WendiCo Atlantic Ltd.656432 Weness Global Ltd.681766 WHISKEY JOE’S LTD.675521 White Pine Builders and Renovators Inc.637138 With Power Property Holdings Inc.656197 Worth A Wiggle Inc.681421 XUAN RESTAURANTS INC.643542 Yves Lagace Flooring Inc.

681724 1353974 ONTARIO INC.077625 1419125 ONTARIO LTD.662454 2296602 Ontario Inc.669269 8450226 Canada Inc.674431 8741824 Canada Incorporated073162 ACME TRUCK LINE, INC.643751 Atlantic Medical Imaging Services Inc.681395 AUTOMATED LOGIC - CANADA,

LTD.669233 BAYER CROPSCIENCE INC.675164 BOUDREAU CERAMIC

INSTALLATION INC.681541 BROWN’S PAVING LTD.656148 CLINIQUE LASER JOUVENCE INC.611641 Comark Inc.605733 CONSTRUCTION MARKET DATA

GROUP INC.

630539 Cott Corporation Corporation Cott662455 CRC RV CENTRE LTD.656200 Credit Suisse Securities (USA) LLC668991 Dalmack Holdings Ltd.669270 Dr. I. Andonov P.C. Inc.681769 EDEN PARK INC.075343 EXCALIBUR Learning Resource Centre,

Canada Corp.653658 Hubert Blanchette Inc.681467 iQor Canada Ltd

iQor Canada Ltée669159 J. Haarsma Dairies Ltd.649943 Live Nation Canada, Inc.600095 LUMA GÉNÉTIQUE INC

LUMA GENETIC INC.675368 Malmac Innovations Corp.

662723 McKesson Health Management Services ULC/

McKesson, Services De Gestion Sante ULC

637278 MDM Mechanical & Consulting Inc.643336 Monavie Enterprises Canada ULC662887 MVL Leasing Limited077106 Q.I.P. Equipment Ltd

Equipement Q.I.P. Ltee681134 RANGOT LLC662834 RASAKTI INC.675500 Spartan Athletic Products Limited675324 Strategic Edge Chartered Financial

Consulting Inc.600014 SYSCO INTERNATIONAL, ULC076658 Tulsa Inc.669004 UNIDEM SALES INC.

____________________

Notice of decisionto cancel the registration of extra-provincial corporations

Take notice that the Director under the Business Corporations Act hasmade a decision to cancel the registration of the following extra-provincial corporations pursuant to paragraph 201(1)(a) of the Act, asthe said corporations have been in default in sending to the Directorfees, notices, and/or documents required by the Act. Please note that60 days after the publication of this Notice in The Royal Gazette, theDirector may cancel the registration.

____________________

Avis d’une décisiond’annuler l’enregistrement des corporations extraprovinciales

Sachez que le directeur, en application de la Loi sur les corporationscommerciales, a pris la décision d’annuler l’enregistrement des corpo-rations extraprovinciales suivantes en vertu de l’alinéa 201(1)a) de laLoi, puisque lesdites corporations ont fait défaut de faire parvenir audirecteur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi. Soyez aviséque 60 jours après la date de la publication du présent avis dans laGazette royale, le directeur pourra annuler l’enregistrement desditescorporations extraprovinciales.

Page 5: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 183 Gazette royale — 15 février 2017

643489 ACTIVE CHARLO ACTIF INC.009131 AGENCE DE DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE DE KENT INC.-KENT COMMUNITY

ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY INC.

021809 AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERS ASSOCIATION (ATLANTIC) INC.

000701 ARGOSY PUBLICATIONS INC.669276 ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS

COLLÉGIAUX DU CAMPUS DE BATHURST (AECCB) INC.

662967 ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE BLEUETS SAUVAGES DU NORD-EST DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.

605970 Believers of Oneness Pentecostal Church Inc.

024153 BELLEDUNE RIVER CEMETERY INC.

656489 BOSCA BURAGLIA PARK INC.643793 Brunswick Street Baptist Church Ltd.002581 BURNT CHURCH NEW JERSEY

RECREATION COUNCIL INC.630498 Chambre de commerce française au

Canada - Réseau atlantique Inc.681551 Charlotte County Rifle Association Inc.022123 CLUB D’AGE D’OR DE PRE-D’EN-

HAUT INCORPORE022095 CLUB D’AGE D’OR NOTRE DAME

DE LA PAIX, INC.024575 CLUB DE GOLF REGIONAL

TABUSINTAC REGIONAL GOLF AND COUNTRY CLUB INC.

013318 CLUB RICHELIEU FREDERICTON INC.

643414 CLUB VTT SWAMP RUNNER INC.669280 Codiac Concert Band/Harmonie Codiac

Inc.025719 COMMISSION DU TOURISME

ACADIEN DU CANADA ATLANTIQUE INC.

025718 EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION NEW BRUNSWICK INC.

SOINS ET ÉDUCATION À LA PETITE ENFANCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.

662580 ER DOCTORS OF THE MONCTON HOSPITAL INC.

675702 FONDATION DU CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE DU MADAWASKA INC.

668974 Fredericton Community Bicycle Organization (F.C.B.O.) Inc.

024908 GRACE BAPTIST CHURCH (INDEPENDENT) OF MONCTON, INC.

649774 GRAND BAY-WESTFIELD ATV RIDERS INC.

009171 KESWICK VALLEY ROBIN GROUP SENIOR CITIZENS INC.

617479 KINGS EAST DEVELOPMENT PARTNERSHIP INC.

636964 LE CHOEUR LOUISBOURG Inc.631000 Maple Leaf Villa Inc.023156 MILLER BROOK HARBOUR

AUTHORITY INC.011042 MIRAMICHI BOATING AND YACHT

CLUB INC.011211 MONCTON ART SOCIETY INC.012106 MOUNT ALLISON FEDERATED

ALUMNI669310 Muslim Community Centre Saint John

Inc.662838 NEW BRUNSWICK ASSOCIATION

OF ONSITE WASTEWATER PROFESSIONALS INC./

ASSOCIATION DES PROFESSIONELS DES SYSTÈMES AUTONOMES*

012053 NEW BRUNSWICK AUTOMOBILE DEALERS’ ASSOCIATION INC.

024152 NEW BRUNSWICK FOUNDATION FOR THE ARTS INC./

FONDATION DES ARTS DU NOUVEAU BRUNSWICK INC.

681681 New Brunswick Powerlifting Association Inc.

023684 NEW BRUNSWICK TOURISM GRADING AUTHORITY INC.

024906 NEW DENMARK SENIORS’ COMPLEX INC.

600003 Northside Youth Centre Inc.021802 Office du tourisme de la Péninsule

acadienne Inc.012618 OROMOCTO MALL MERCHANTS

ASSOCIATION INC.021815 PARC DE LA VALLEE DE

MEMRAMCOOK, INC.025089 PORT CITY DANCE ACADEMY INC.600000 Purdy’s Corner Townhouse Association

Inc.656531 Riverside Estates Townhouses Inc.014320 ROTARY CLUB OF GRAND FALLS

INC.611587 ROTARY CLUB OF PORT ELGIN,

N.B. INC.014512 SACKVILLE LIONS CLUB INC.630786 SERVICES PALLIATIFS

COMMUNAUTAIRES CHALEUR INC./

CHALEUR PALLIATIVE COMMUNITY SERVICES INC.

021557 SJHS ALUMNI FUND INCORPORATED

669401 Slate Island Wilderness Club Inc.617864 St. John Basin Salmon Recovery Inc.650178 SYNERGIES CHALEUR INC.015956 TABUSINTAC RECREATION

COUNCIL INC.656307 TADD N.B. INC.025699 THE EVANDALE COMMUNITY

WHARF COMPANY LIMITED617472 THE JOSHUA EVANS’ TRUST INC.015457 THE SPIRITUAL ASSEMBLY OF THE

BAHA’IS OF SAINT JOHN INC.021551 VAL LAMBERT RECREATION

COUNCIL INC.024159 VELO N.B. INC.

Avis d’une décision de dissoudre les compagnies provincialesSoyez avisé que le directeur, en application de la Loi sur les compa-gnies, a pris la décision de dissoudre les compagnies suivantes en vertude l’alinéa 35(1)c) de la Loi, puisque lesdites compagnies ont fait dé-faut de faire parvenir au directeur les droits, avis et/ou documents re-quis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date de la publicationdu présent avis dans la Gazette royale, le directeur pourra dissoudrelesdites compagnies.

Loi sur les compagnies

Notice of decision to dissolve provincial companiesTake notice that the Director under the Companies Act has made a de-cision to dissolve the following companies pursuant to paragraph35(1)(c) of the Act, as the said companies have been in default in send-ing to the Director fees, notices, and/or documents required by the Act.Please note that 60 days after the date of publication of this Notice inThe Royal Gazette, the Director may dissolve the companies.

Companies Act

Page 6: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 184 Gazette royale — 15 février 2017

623813 Archambault, Neathway & Rideout Approachable Accountant

661498 Bar VIP623638 Belyea Colwell Daley, Chartered

Professional Accountants661483 Droit Veritas Law661281 Faces Magazine Fredericton661907 Half Mile Lane Farm

661617 Hilton Spring Farm661514 JD’S HERITAGE VARIETY661764 KALIE’S BUTTERFLIES661113 MARKKEN ENTERTAINMENT623669 Mother Mouse’s Collectibles661547 NEW YOU SLIMMING WRAPS660808 PRODUITS FORESTIERS ARBEC

S.E.N.C.

661686 Rowan McGrath Lawyers351154 SilverKing Restaurant660868 Soucy Tower Systems661591 Takes Two Farm661494 The Davis & Lee Financial Planning

Centre623900 Verus Consulting

623616 “Allusions” Hair Design348700 “Leamans” Repair Shop661735 625 Route 10 Highway Automotive623793 A Plus Quality Services623817 A1 TAXI623770 AAA Storage348808 Abby Glen Riverfront B & B623764 Ace Door Hardware661910 ADRIAN FORGIE BUILDER

CONTRACTOR661671 Agence basKASTing Agency623658 Amenagement M.L.Poirier661537 Andy Storr’s Auto661709 Anne Graham, Licensed Psychologist623708 APPLEBY PROPERTY

MANAGEMENT661451 ATLANTEK E-STORE623746 ATLANTIC BUILDING INSPECTORS348601 Atlantic Speakers Bureau623557 AUTISM INTERVENTION SERVICES623637 Avila Estate348768 Backflow Prevention & Testing Services623544 BALEMANS PRODUCE661756 Bar Ailleurs chez katoo661649 BAR CHEZ KINE661919 Barachois Vehicle Import Personal Auto

Sales661474 Barron T. Labour Relations661642 Barton’s Auto Salvage & Towing661876 Batstra Construction

661613 Bay of Fundy Adventures661940 BDLAW661689 Bear Island Consulting661944 BeeLine Furniture661496 Ben & Ed “da boys” Flowers, Gifts and

Home Decor661692 Beth’s Travel661406 Black Door Studio Salon & Spa351162 Break Thru Solutions661433 Brose Enterprise661823 BROTHERS BEAUTY SUPPLY661697 Buanderie Dieppe Laundry351185 BUCKWHEAT PETE DIGITAL

PRODUCTIONS661582 BUON APPETITO RESTAURANT &

GROCERY STORE661804 Busy B’s Drywall & Carpentry661826 C E Salmon Flies & Guiding348599 C K FISH BUYER623688 C’MON INN348767 CAD 2000348784 CALEDONIA TANK WASH353373 CANADA ENTERPRISES

STEVEDORING AND TERMINALS680868 Cara’s Beauty Magic660542 Carolle Manicure Plus Salon353277 CCS - Complete Computer Service623720 Chalets de la mer rouge661758 CHARLIE ALLAIN TRUCKING338142 CHEERS BEVERAGE ROOM

661042 Chenil AKKADA / AKKADA Kennel661895 Chris Parks Trucking661093 Church Army in Canada623982 City & District Web Development661732 Clean-Rite General Services661583 Clinique Après-Heures/After Hours

Clinic (Dr. Danny Thibeault)346055 CNC GLOBAL CONSULTING346054 CNC GLOBAL SEARCH661652 Colin Spares Painting338272 COMSTOCK CANADA661708 Craig MacArthur Trucking661728 D & A Meats661609 Dawson Career Development & HR

Solutions661437 DC’s Small Engine Express340991 DEBLY FOREST PRODUCTS340992 DEBLY LOGGING348594 Desroches Canteen661428 DESTINY ANCHORED ADVISORY

SERVICES661478 DMSS SAFETY SERVICES ENR.661519 Doggy Depot661822 Dunhams Run Estate Winery661410 EARTH TO EARTH POTTERY661909 East Coast Liquidators348739 Eds Fish & Chips661679 Edwin Silliker Trucking661699 Energi of Canada623737 England Electric

SACHEZ QUE, conformément aux articles 12.3 et 12.31 de la Loi surl’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations com-merciales, L.R.N.-B. de 1973, ch. P-5, le registraire a l’intention, envertu de ladite loi, d’annuler l’enregistrement des certificats de sociétésen nom collectif indiquées à l’annexe « A » ci-jointe et des certificatsd’appellations commerciales des commerces indiqués à l’annexe « B »ci-jointe, en raison du fait que ces firmes ou commerces ont négligé defaire enregistrer des certificats de renouvellement conformément àl’alinéa 3(1)b) ou c) ou au paragraphe 3.1(2) ou 9(7) de ladite loi, selonle cas.

SACHEZ AUSSI qu’en tout temps après la date d’expiration de trente(30) jours à partir de la date de publication du présent avis, le registrairepeut annuler l’enregistrement desdits certificats de sociétés en nomcollectif et certificats d’appellations commerciales.

Loi sur l’enregistrement dessociétés en nom collectif et

des appellations commerciales

TAKE NOTICE that, pursuant to sections 12.3 and 12.31 of the Part-nerships and Business Names Registration Act R.S.N.B., 1973, c. P-5,the Registrar under the said Act intends to cancel the registration of thecertificates of partnership of the firms set forth in Schedule “A” an-nexed hereto and the certificates of business names of the businessesset forth in Schedule “B” annexed hereto by reason of the fact the saidfirms and businesses have failed to register certificates of renewal inaccordance with paragraph 3(1)(b) or (c) or subsection 3.1(2) or 9(7),as the case may be applicable, of the said Act.

FURTHER TAKE NOTICE that at any time after the expiration date ofthirty (30) days from the date of publication of this Notice, the Regis-trar may cancel the registration of the said certificates of partnershipsand certificates of business names.

Partnerships and BusinessNames Registration Act

Schedule “A” / Annexe « A »Certificates of Partnerships / Certificats de sociétés en nom collectif

Schedule “B” / Annexe « B »Certificates of Business Names / Certificats d’appellations commerciales

Page 7: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 185 Gazette royale — 15 février 2017

661157 Equipping Evangelists Ministry623976 Ero Investments623713 Estey Creations661790 Esthétique Sublime661596 EW Design661838 FACE-IT GENEVIÈVE661639 Fairvale Physiotherapy Clinic661668 Fancy Cutz and Stylez661897 FHL Cleaning Services338224 FIBRENEW MONCTON661713 Flat Top Music661636 Footprints Wellness Consulting623786 Forbes Insurance630234 FOREST PRODUCTS TERMINAL630236 FORTERM661524 From The Ground Up Enterprises661648 Fundy Flair For Hair661463 G.C. Dream Homes Construction623789 G.R.M. Automotive623650 Galancor Surgical661489 GALBRAITH PIANO SERVICES661674 Gallerie LeBouthillier661828 Garderie Petits Moineaux661414 Gautam LeBlanc & Associates661769 GeoMax Energy661607 Gerald J LeBlanc Trucking661598 Gillespie Express Painting Services661680 Glen Silliker Trucking661625 GOLD BUYERS NEW BRUNSWICK629580 Golden Music Shop Enr.661946 GOLDEN SUSHI & THAI351059 GOLDSMITH STUDIO623849 H S C FABRICATION351103 H.E. HAWKER FOREST

CONSULTING623709 hbj Consulting661623 Hidden Hollow Farm623882 High Tide Hair Design661789 HILLBILLY HAULAGE661844 Hubert Williston Renovations and

Construction661599 IAN BELYEA EXCAVATING661809 Infiniti Tattoos and Piercing Studio661531 J & Q BUILDING AND

RENOVATIONS661536 Jack & Jill’s Indoor Playland661546 JETOY FANCY STATIONARY661587 JG CENTRALVAC AND SERVICES661601 JJJ ELECTRICAL661900 JOE’S WOODWORKING661454 Johnson Pottery661911 JPS SIGNS AND IDENTIFICATION

SOLUTIONS661850 JUNK & STUFF PICKUP661581 JW MARITIME RENOS661529 Kandise Brown Creative661614 Kane Construction661729 KANE HOMES351008 KEITHBILT CONSTRUCTION661739 Kevin Dinsmore Painting623582 Kierstead Mountain Gun Shop343465 KIM LONG RESTAURANT661816 KING PERFORMANCE661464 Krista’s Gifts & Decor661763 KV VINEYARD661573 L’Entracte Resto Pub623724 LA MARCHANDE DE FLEURS (2006)

ENR.661622 La vieille école de Miscou

661863 LAUNCH!661917 LAURA COMEAU ART629735 Lavender Lane Cottage623428 LES ENTREPRISES J.T. ENTRETIEN

MENAGER COMMERCIAL661517 Libyana Auto Sales340891 LIFE BALANCE661754 LIFTWORKS ATLANTIC623845 Lookin Sharp348616 LORMAN EDUCATION SERVICES661647 LUNA TAROT READINGS661643 Lundy Avionic624043 M.A.C. Vacuum623581 MacBine Variety623997 MAINSTREAM AUTO & SPEED661724 MAISONS LEVESQUE661694 MAPLE COVE SMALL BUSINESS

BOOKKEEPING661495 Master Masonry Brick Repair &

Restoration661418 MB Holland Sales Agency661848 MCGUIRE REHAB RENOS661849 MCGUIRE’S TRINKETS &

TREASURES661736 MELROSE ROCK & FILL CO.348503 MICHELLE’S CREATIVE LOOKS661657 Miramichi Northwest Lodge351188 MIRAMICHI SHUTTLE SERVICE661801 Miranda Gowns661814 MISSION OUTDOOR ADVENTURE661815 Modern Hüs623956 Molico Enterprises661107 MONCTON CRUISESHIPCENTERS661780 Moncton Kiwanis Basketball Association348631 MOUNT PLEASANT FARMS661912 MR HANDYMAN BY SERGE351093 MUNSON AUTOMOTIVE661533 Naturothérapie L’Estrella661824 Nava Yoga Studio661479 Nellie’s Duck less Heat Pumps661459 Nickmann Enterprises661925 NINE-DOT MARKETING661935 NLB Nuclear Process Services351143 Norbert’s Trucking661172 NORTH SHORE CINEMA661520 Off Kilter Bike351009 OPTIMUM RIDE CHARTER SERVICE661915 Oromocto Dental Health Centre661595 PARLEE CARPENTRY661558 Parlour Pawn624066 PARTINGTON TRUCKING630444 Patty Cakes351223 PERRON’S APPRAISALS661438 Pete’s Janitorial661476 Petplan661938 Phil’s Automation Industrial Control

Systems661574 Physio Energie RAMRA351228 PICTURES IN THREAD661738 Prescott Farms623947 PROFESSIONAL CARPET SYSTEMS661888 Progress at Home Physiotherapy661886 Quad B Adventures351053 R & H Interior Finish661553 R. CAISSIE INTERIOR MOTIVES

PAINTING & CRACKFILLING661904 R. Nason Renovations661788 Raduga Market

661554 Ramonage & Déneigement De Toiture de la Péninsule Acadienne

623925 Rankin Photography661539 Relation Canada Atlantique661773 RENT-A-CENTRE623766 Résidence A.D.661662 River Valley Ventilation & Heating351090 Riverview Chiropractic Clinic661677 Riverview’s Quilt Craft Distributors351182 RODSTERS AUTO BODY & REPAIR661695 Roger Maillet Trucking351101 ROYAL LEPAGE - Town & Kountry

Realty661890 RRNJ Style Sales661920 S. Macphee Auto Salvage623958 Sagrati’s661834 SAILBLOG.NET325441 SALON DE BARBIER CLIPSO

BARBER SHOP661663 Salon l’AQUA’fure Jessica661730 Salon Milady661490 Samgaz661659 Service d’Aide à l’Apprentissage du

Nord-Ouest661865 SNACKMAN VENDING SERVICES353229 STEPHENSON MAPLE FARMS661696 STEVEN HARDING TRUCKING661664 Stever-Ryu Jujutsu624024 STEVES AUTO PARTS661162 Street Hope Ministries661444 StudioRouge Photography661431 SUNBURY FUNERAL HOME661535 SUNNYBROOK FARM661875 Sussex Ventilation & Heating661926 Sweetstix Treats661669 SWIT SWOO SERVICES630185 TB & B Holdings351074 TD NEWCREST661778 TEAM BESLER624067 Team X Racing Performance/Repair660897 Technosub661485 TeriDonald Fitness661452 The Atlantic Gold and Silver Centre661734 The General Store St. Andrews617348 The Pepsi Bottling Group (Canada)338125 THE QUILT EMPORIUM661466 The Right Path Allergy Treatment629585 Therapeutic Touch Nicole Dufour-Allen

RMT351128 THUG ENGINE WORKS by AM661722 Tidal Pool Software636207 TODAYS STAFFING661506 Tom’s Full House Bar661492 Tradewinds Truck Service662095 Tug It Trailer Sales661899 U’n’I CATERING661879 VÂN’s NAILS661752 VETEMENTS O BON PRIX ENR.623653 VICTOR’S GROOMING PLACE661584 Videosphere Presentations661673 Viva Fitness Studio661691 W. H. Martin Creations from the Past661116 Walt’s Carpentry353504 WaterMaster Treatment Reg’d623806 Weezie Novelties340939 WESTAGRO353304 WESTFIELD BEACH ENTERPRISES661417 Y.H DREAM SECURITY661878 Yellowline Vending

Page 8: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 186 Gazette royale — 15 février 2017

The Savvy Entrepreneur’s Self-Sufficiency Service Inc.Service d’auto-suffisance pour l’entrepreneur avisé inc.

Memramcook 693487 2017 01 24

Sankara Cuisine Ltd. Saint John 693609 2017 01 21

MORD NATURAL FOOD ALLIANCE LTD. Saint John 693728 2017 01 17

DalCor Properties Inc. Grand-Barachois 693752 2017 01 17

Keswick Loggers INC. Burtt’s Corner 693767 2017 01 18

Mill Studio Associates Inc. Fredericton 693789 2017 01 19

Dr. Hila Zommer Professional Corporation Campbellton 693790 2017 01 19

Panoramic Events Inc. Woodstock 693792 2017 01 19

Consultants OVI Consultants Inc. Moncton 693795 2017 01 19

Beaverhill Furniture Trading Limited Moncton 693799 2017 01 19

Greg’s Power Sports & Service Center Ltd. Lindsay 693800 2017 01 19

Multi Task Construction Inc. Saint John 693806 2017 01 19

Halcyon Investments Corporation Saint John 693807 2017 01 19

693808 NB Ltd. Rothesay 693808 2017 01 19

Loyalist Lock and Key Ltd. Saint John 693809 2017 01 19

VAPE CANDY INC. Minto 693815 2017 01 20

MATTATALL GROUP INC. Moncton 693821 2017 01 20

Frederick Fernandez Professional Corporation Saint John 693824 2017 01 20

693825 NB INC. Haut-Lamèque 693825 2017 01 20

TERRATRUST NB HOLDINGS INC. Moncton 693826 2017 01 20

693827 N.B. Inc. Moncton 693827 2017 01 20

Wisely Consulting Ltd. Dieppe 693828 2017 01 20

Wei Excavation Limited Saint John 693831 2017 01 20

COMINTRAFIC LOGISTIC CORP. Moncton 693840 2017 01 20

ECOP Enterprises Inc. Dieppe 693842 2017 01 20

693843 N.B. Ltd. Dipper Harbour 693843 2017 01 20

Harvona Contracting Inc. Bloomfield Ridge 693844 2017 01 20

Leras Horsepath Inc. Saint-leonard 693845 2017 01 20

693846 N.B. Ltd. Dipper Harbour 693846 2017 01 20

Loi sur les corporations commercialesBusiness Corporations Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of incorporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commer-ciales, un certificat de constitution en corporation a été émis à :

ReferenceNumber Date

Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

Page 9: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 187 Gazette royale — 15 février 2017

J.G. Dunn Enterprises Inc. Willow Grove 693847 2017 01 20

MARITIME METAL DETECTORS LTD. Saint John 693850 2017 01 20

Aaron’s Automotive Inc. Bathurst 693851 2017 01 20

693857 NB Ltd. Moncton 693857 2017 01 21

693861 N.B. Inc. Saint John 693861 2017 01 23

Unit Talent Consulting Inc. Saint John 693863 2017 01 23

T.M.S. MANUFACTURING INC. Beechwood 693865 2017 01 23

Vukovic Transportation Inc. Fredericton 693871 2017 01 23

RRI Renew Recycle International Inc. Moncton 693874 2017 01 23

Fiddlehead Power Inc. Fredericton 693875 2017 01 24

Canso Properties Ltd. Dieppe 693886 2017 01 24

693889 NB Ltée Lamèque 693889 2017 01 24

Momentum Canada Skills Development Inc. Saint John 693898 2017 01 24

693899 NB LTÉE Caraquet 693899 2017 01 24

Poutine Palace Ltd. Moncton 693903 2017 01 24

693904 NB Inc. Saint John 693904 2017 01 24

Susan M. Hunter Holdings Inc. Rothesay 693909 2017 01 25

693910 N.B. Inc. Rothesay 693910 2017 01 25

RL Holdings Inc. Long Reach 693912 2017 01 25

Hive Engineering Limited Fredericton 693913 2017 01 25

Janus Transport Inc. Woodstock 693914 2017 01 25

Diversified Refrigeration Works Inc. Shediac Cape 693922 2017 01 26

TerraSea Group Inc. Moncton 693925 2017 01 26

Lighthouse Holding Corporation Saint John 693930 2017 01 26

693968 N.B. LTD. Mont Eagle 693968 2017 01 27

_____________________________________________________

Dr. Ronald Arthur Francis Medicine ProfessionalCorporation

Lincoln Ontario 693873 2017 01 23

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpo-rations Act, a certificate of continuance has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de prorogation a été émis à :

Previous ReferenceJurisdiction Number Date

Registered Office Compétence Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré antérieure référence année mois jour

Page 10: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 188 Gazette royale — 15 février 2017

ELMER MARASE RIOUX BULLDOZING SERVICE LTD. 510850 2017 01 20

Cro-Bel Inc. 611822 2017 01 20

D. W. KYDD HOLDINGS INC. 645554 2017 01 23

L & R Landing Corporation 649360 2017 01 19

Brett Chevrolet Cadillac Buick GMC Ltd. 680269 2017 01 23

688132 NB Inc. 688132 2017 01 24

Brewester Marine Inc. 689599 2017 01 23

690515 NB Inc. 690515 2017 01 22

691680 N.B. Inc. 691680 2017 01 25

Roche Papier Studio - Moncton Inc. 691787 2017 01 19

693251 NB Inc. 693251 2017 01 23

Copper Key Realty Ltd. 693626 2017 01 25

_____________________________________________________

604711 NB INC. DÉPANNEUR LAMÈQUE INC. 604711 2017 01 24

GWD Forestry Ltd. GWD Admin Ltd. 683952 2017 01 25

_____________________________________________________

COGSWELL PROPERTIES LTD. Cogswell Properties Ltd. Saint John 693860 2017 01 23TG Charlie Grace Terrace Ltd.

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment which includes a change inname has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification contenant un changement de raisonsociale a été émis à :

DatePrevious name Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amalgamation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de fusion a été émis à :

ReferenceNumber Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Registered Office Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes Bureau enregistré référence année mois jour

Page 11: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 189 Gazette royale — 15 février 2017

665785 N.B. Inc. Saint John Powell Associates Ltd. 665785 2017 01 24

_____________________________________________________

Parkside Enterprises Inc. Canada 664152 2016 12 20

_____________________________________________________

617809 N.B. Ltd. 617809 2017 01 18

Doak’s Plumbing & Heating Ltd. 636212 2017 01 23

EDUCAIDE TUTORAT INC. 641920 2017 01 17

665834 N.B. Inc. 665834 2017 01 18

_____________________________________________________

Coöperatieve Rabobank U.A. Pays-Bas /Netherlands

McInnes Cooper CSD Services Inc.Fredericton

693812 2017 01 20

KASSIRER ASSET MANAGEMENT CORPORATION

Ontario Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

693864 2017 01 23

Canadian Plasma Resources Corporation Canada Kyle FirlotteMoncton

693870 2017 01 23

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, notice of the discharge of a receiver or a receiver-manager of the following corporations has been received:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un avis de libération d’un séquestre ou séquestre-gérant pour lessociétés suivantes a été reçu :

Receiver or ReferenceReceiver-Manager Number Date

Registered Office Séquestre ou Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré séquestre-gérant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of discontinuance has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de cessation a été émis à :

DateJurisdiction of Continuance Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Compétence de prorogation Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of revival has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de reconstitution a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of extra-provincial corporationhas been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a étéémis à :

ReferenceNumber Date

Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour

Page 12: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 190 Gazette royale — 15 février 2017

GREEN TAG SERVICES INC. Canada Docu-Tek Inc.Fredericton

693883 2017 01 24

ADAPT PHARMA CANADA LTD. Colombie-Britannique /British Columbia

Deborah M. PowerFredericton

693908 2017 01 24

REINSURANCE MANAGEMENT ASSOCIATES, INC.

Ontario McInnes Cooper CSD Services Inc.Fredericton

693929 2017 01 26

TORA BATHURST (222) LIMITED Canada Todd PotterQuispamsis

693931 2017 01 26

CANADIAN CONTINENTAL EXPLORATION CORP.

Canada Garth GravesBathurst

693938 2017 01 27

PETER KIEWIT SONS ULC Colombie-Britannique /British Columbia

Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

693947 2017 01 27

CHES SPECIAL RISKS INC. Canada Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

693949 2017 01 27

HIPTURF INC. Canada Brody HansonCharters Settlement

693952 2017 01 27

TALKFOOD INC. Canada Prince BrownFredericton

693966 2017 01 27

_____________________________________________________

Caleres Canada, Inc. Brown Shoe Company of Canada Ltd / Chaussures Brown du Canada Ltee

077983 2017 01 26

Soucy Aquatik inc. Piscines Soucy Inc. 652367 2017 01 26

DOTERRA MARKETING CANADA ULC FLORESSE CANADA ULC 686886 2017 01 23

_____________________________________________________

LIFEMARK HEALTH CORP. LIFEMARK HEALTH CORP. Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

693837 2017 01 20

BSM TECHNOLOGIES LTD. WEBTECH WIRELESS INC. Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

693838 2017 01 20

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment of registration of extra-provincial corporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification de l’enregistrement de corporationextraprovinciale a été émis à :

ReferenceNumber Date

Previous name Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Ancienne raison sociale référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of amalgamated corporationhas been issued to the following extra-provincial corporations:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovincialeissue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales sui-vantes :

ReferenceAgent and Address Number Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Représentant et Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes adresse référence année mois jour

Page 13: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 191 Gazette royale — 15 février 2017

ARRIS CANADA, INC. ARRIS CANADA, INC. Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

693882 2017 01 24

CASCADES CANADA ULC CASCADES CANADA ULC Willard M. Jenkins 693891 2017 01 24Saint John

Tiber River NaturalsIncorporated

Terra Laboratories &Consultants, Inc.

Bruce M. LoganSaint John

693895 2017 01 24

THE JUICE PLUS COMPANY(CANADA) INC.

THE JUICE PLUS COMPANY(CANADA) INC.

Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

693927 2017 01 26

Arthur J. GallagherCanada Limited

Arthur J. GallagherCanada Limited

Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

693928 2017 01 26

AT&T GLOBAL SERVICESCANADA CO.

AT&T GLOBAL SERVICESCANADA CO.

Willard JenkinsSaint John

693934 2017 01 26

L’Association des familles Arsenault Family Association Inc. 645157 2017 01 23

Northwest Resource Center for Newcomers Inc.Centre de ressources pour nouveau arrivants au Nord-Ouest Inc.

650120 2017 01 19

Snow’s Softserve Burgers at Busters Inc. Hampton 693624 2017 01 20

Snow’s IceCream Burgers at Busters Inc. Hampton 693625 2017 01 20

XTR Energy WORLD FUEL SERVICESCANADA, ULC

Fredericton 693681 2017 01 27

Youngevity Mialisia Canada Inc. Moncton 693736 2017 01 17

Ever After Bridal Boutique Corie O’Neill Saint John 693758 2017 01 18

Loi sur les compagniesCompanies Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that the charter of the followingcompany is revived under subsection 35.1(1) of the Companies Act:

SACHEZ que la charte de la compagnie suivante est reconstituéeen vertu du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les compagnies :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des

appellations commercialesPartnerships and Business Names

Registration ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and

Business Names Registration Act, a certificate of business name hasbeen registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appel-lation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Page 14: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 192 Gazette royale — 15 février 2017

Future Inboundesign Abdellatif Baoud Moncton 693777 2017 01 18

RIZEUP Boxing & Fitness Center Dwayne Storey Moncton 693778 2017 01 18

Loch Lomond property Maintenance Chris Grimmer Saint John 693781 2017 01 18

HiTech Dairy Damien Constantine Riverview 693786 2017 01 19

Lud-San Enterprises Combined Holdings &Investments Ltd.

Hanwell 693787 2017 01 24

S&D SEA SIDE FAMILYRESTAURANT

Stephen Stewart Orange Hill 693794 2017 01 19

Riverview Appliance Repair Roger William Airey Riverview 693801 2017 01 19

Stiletto Salon & Spa Kendall Rolfe Moncton 693805 2017 01 19

Little Cloud Kites Leland Wong-Daugherty Knowlesville 693810 2017 01 19

Rabobank Canada Coöperatieve Rabobank U.A. Fredericton 693813 2017 01 20

Innovative Hybrid Wrestling Kevin Gilmore Moncton 693814 2017 01 20

Lexi Rose Collection Sarah MacPherson Upper Coverdale 693820 2017 01 20

Productions Baskusse Musique Serge Basque Dieppe 693822 2017 01 20

Mark Anthony Wine & Spirits MARK ANTHONY GROUP INC. Saint John 693833 2017 01 20

Mitchell Mill Systems Canada Ag Growth International Inc. Saint John 693835 2017 01 20

Westeel Canada Ag Growth International Inc. Saint John 693836 2017 01 20

Solutions Décor Nathalie Godbout-Bourgeois Shediac Cape 693848 2017 01 27

Tourbillon Farm Duncan Godfrey Lakeside 693852 2017 01 20

Hot Shots Pressure Washing Justin Gallant Moncton 693853 2017 01 20

The Original Pickle Guy Ken Bustin Fairhaven 693855 2017 01 21

Skapandi Crafts Diane Ward Fredericton 693856 2017 01 21

Focused Dogs Dog Training Kristal Proulx Fredericton 693859 2017 01 22

Egg Roll King CAOANH 2016 HOLDING LTD. Riverview 693867 2017 01 23

Raymond Matte appliances & repairs Raymond Matte Campbellton 693868 2017 01 23

LEONARD FILMS AND GRAPHICS Car-Rizma Motorsports Ltd. Saint John 693876 2017 01 24

A BUYERS CHOICE HOMEINSPECTORS SUSSEX

C. W. MELANSONINDUSTRIES LTD.

Quispamsis 693877 2017 01 24

L & T MAINTENANCE SERVICES 673052 NB LTD. Rowley 693878 2017 01 24

CHOOKA MEDIA GROUP CHOOKA GRAPHIC DESIGNSTUDIO LTD.

Saint John 693880 2017 01 24

Brookside Lawn and Garden Adam Theriault Indian Mountain 693893 2017 01 24

The Call Guys Serge Noel Moncton 693896 2017 01 24

AcadiaBore Video Productions Pierre Cormier Dieppe 693905 2017 01 24

Eye Do Lashes Norah Keohan Moncton 693906 2017 01 24

RIVER GLEN AMPHITHEATRE Allied Industries Limited Moncton 693907 2017 01 24

Page 15: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 193 Gazette royale — 15 février 2017

Why Pay More Discount Store THE BRODY COMPANY LTD Quispamsis 693932 2017 01 26

Food by Number Atlantic Pocket Inc. Fredericton 693945 2017 01 27

_____________________________________________________

NEW BRUNSWICK SPORT FISHING ASSOCIATION

Terry TaylorBertramn BeekRobert Sheils

Mazerolle Settlement 328012 2017 01 27

HAVELOCK FUNERAL PARLOUR SALISBURY FUNERALHOME LTD.

Havelock 340615 2017 01 19

Salon R.J. Savoie SERVICE CORPORATIONINTERNATIONAL (CANADA) ULC

Val d’Amour 345301 2017 01 20

Rebecca Farm Bed & Breakfast W & J CRAIG HOLDINGS LTD. Rockland 348419 2017 01 19

Interprovincial Coach Lines Ocean Finance, LimitedFinance Océan Limitée

Saint John 348454 2017 01 23

Ocean Finance Ocean Finance, LimitedFinance Océan Limitée

Saint John 348455 2017 01 23

Belledune Industries Ocean Finance, LimitedFinance Océan Limitée

Saint John 348456 2017 01 23

Irving Industries Ocean Finance, LimitedFinance Océan Limitée

Saint John 348457 2017 01 23

Fairview Development Ocean Finance, LimitedFinance Océan Limitée

Saint John 348458 2017 01 23

CÔTÉ’S BED & BREAKFAST Norma Côté Grand-Sault / Grand Falls 348480 2017 01 24

MAHER’S FUNERAL HOMES SERVICE CORPORATIONINTERNATIONAL (CANADA)ULC

Dalhousie 350593 2017 01 20

SALON FUNERAIRES MAHER SERVICE CORPORATIONINTERNATIONAL (CANADA)ULC

Balmoral 350594 2017 01 20

B.A.S.A. RÉPARATIONS & SERVICES

Frederic Savoie Balmoral 350623 2017 01 23

Chateau de Champlain Retirement JOHN RETIREMENT GROUP LTD.

Saint John 350762 2017 01 23

Residence

LIBERTY INTERNATIONALUNDERWRITERS CANADA

Liberty Mutual InsuranceCompany

Saint John 352368 2017 01 27

SALONS FUNERAIRES MAHER SERVICE CORPORATIONINTERNATIONAL (CANADA)ULC

Campbellton 354165 2017 01 20

Vallen Safety HAGEMEYER CANADA INC. Saint John 600133 2017 01 20

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of businessname has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement d’appellation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Page 16: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 194 Gazette royale — 15 février 2017

Salons funéraires Maher’sFuneral Home

SERVICE CORPORATIONINTERNATIONAL (CANADA) ULC

Campbellton 611510 2017 01 20

EZ HOTTUB RENTALS Donald Currie Quispamsis 623196 2017 01 23

Seawind Beads Ineke de Vries Grand Manan 624164 2017 01 24

Candid Critters Animal Photography Robyn Shortt Fredericton 630806 2017 01 20

BRAUN CANADA PROCTER & GAMBLE INC. Moncton 631393 2017 01 26

CITIFINANCIAL RETAIL SERVICES

CitiFinancial Canada, Inc.CitiFinancière Canada, Inc.

Saint John 642422 2017 01 27

Interfleet BSM TECHNOLOGIES LTD. Saint John 660090 2017 01 20

Maher’s Crematorium SERVICE CORPORATIONINTERNATIONAL (CANADA) ULC

Campbellton 655639 2017 01 20

Interfleet BSM TECHNOLOGIES LTD. Saint John 660090 2017 01 20

Les trois Poiriers Agriculture Josée Lévesque Saint-Louis 660213 2017 01 19

Simply Sarah Day Spa Sarah Matheson St Stephen 660466 2017 01 20

Onsite Wedding Kris Austin Minto 661056 2017 01 23

LE CLUB DE JUDO HANAGATA Michel Raymond Kedgwick Sud 661108 2017 01 19

Amy’s Quality Care / Home Care Amy Lapointe Gravel Hill 661115 2017 01 24

Charlee Grant RMT RegisteredMassage Therapist

Charlee McLaughlin Grant St Andrews 661242 2017 01 23

ATOUT CULTURE CONSEIL PROVINCIAL DESSOCIETES CULTURELLES, INC.

Moncton 661327 2017 01 24

TD Auto Finance TD AUTO FINANCE (CANADA)INC./FINANCEMENT AUTO TD (CANADA) INC.

Fredericton 661793 2017 01 24

Financement auto TD TD AUTO FINANCE (CANADA)INC./FINANCEMENT AUTO TD (CANADA) INC.

Fredericton 661794 2017 01 24

SERVICES DE FINANCEMENT TD TD FINANCING SERVICESINC./SERVICE DEFINANCEMENT TD INC.

Fredericton 661795 2017 01 24

TD FINANCING SERVICES TD FINANCING SERVICESINC./SERVICE DEFINANCEMENT TD INC.

Fredericton . 661797 2017 01 24

TD Services de financement TD FINANCING SERVICESINC./SERVICE DEFINANCEMENT TD INC.

Fredericton 661798 2017 01 24

Bistro 33 Bistro Thirty-Three Inc. Moncton 661864 2017 01 26

Juice Plus Canada THE JUICE PLUS COMPANY(CANADA) INC.

Saint John 675182 2017 01 26

Pearle Vision Luxottica Retail Canada Inc. Saint John 675809 2017 01 26

Sunglass Hut International Luxottica Retail Canada Inc. Saint John 675810 2017 01 26

Sunglass Hut Luxottica Retail Canada Inc. Saint John 675811 2017 01 26

_____________________________________________________

Page 17: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 195 Gazette royale — 15 février 2017

Zenon Membrane Solutions Saint John 630427 2017 01 26

GE Infrastructure Saint John 630428 2017 01 26

Greg’s Power Sports Lindsay 630574 2017 01 19

Travel Cuts Saint John 647364 2017 01 27

PIZZA AMY Lamèque 655128 2017 01 24

DIVERSIFIED REFRIGERATION WORKS Shediac Cape 661658 2017 01 26

Merit Travel Saint John 677894 2017 01 27

The Adventure Travel Company Saint John 679108 2017 01 27

Stiletto Beautique Moncton 688752 2017 01 19

_____________________________________________________

Dea Rose Swimwear Veronique L. SavoieStephanie R. Bourque

Dieppe 693866 2017 01 18

Kindred Spirit Essentials M.P. Melissa Marie D. PageChristopher Glen Page

Windsor 693892 2017 01 24

Tetagouche Tree Removaland Chipping

Timothy Francis HachéJoseph Patrice Gauthier

South Tetagouche 693940 2017 01 26

_____________________________________________________

Eight Merchant Capital DCP MERCHANT CAPITAL Saint John 692962 2017 01 23

Eight Capital DUNDEE CAPITAL PARTNERS Saint John 692963 2017 01 23

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of cessation of busi-ness or use of business name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessa-tion de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation com-merciale a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of partnership hasbeen registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de so-ciété en nom collectif a été enregistré :

Address of Business Referenceor Agent Number DateAdresse du commerce Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of change of firmname has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de chan-gement de raison sociale a été enregistré :

Address ofBusiness or Agent ReferenceAdresse du Number Date

Previous Name commerce ou Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Ancienne raison sociale du représentant référence année mois jour

Page 18: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 196 Gazette royale — 15 février 2017

The Blue Run John GaudetRosalie Gaudet Patti Driscoll Glenn Driscoll

Saint John 630812 2017 01 23

T&J Gladstone Trucking James GladstoneTodd Gladstone

Colpitts Settlement 660971 2017 01 20

_____________________________________________________

GE CANADA ASSET FINANCING/FINANCEMENT D’ACTIFS GE CANADA

Saint John 622943 2017 01 26

Dalcor Properties Grand-Barachois 685437 2017 01 23

_____________________________________________________

TELE-MOBILE COMPANY EMERGIS INC. 350743 2017 01 26

Bingham Law / Bingham Droit A Kent Robinson ProfessionalCorporationKelsey D. BinghamEmmy ChiassonBrian M. HuntRonald J. Savoy

Kelsey D. Bingham Professional CorporationEMMY CHIASSON PROFESSIONAL CORPORATIONBRIAN M. HUNT PROFESSIONAL CORPORATIONRONALD J. SAVOY PROFESSIONAL CORPORATIONROBERT A. SMITH PROFESSIONAL CORPORATIONMICHIEL J. VANDENBERG PROFESSIONAL CORPORATION

669439 2017 01 23

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of part-nership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement de société en nom collectif a été enregistré :

Address ofBusiness or Agent ReferenceAdresse du Number Datecommerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Partners / Membres du représentant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of dissolution of part-nership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de disso-lution de société en nom collectif a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of change of member-ship of partnership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de chan-gement d’associé d’une société en nom collectif a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Retiring Partners Incoming Partners Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Associés sortants Nouveaux associés référence année mois jour

Page 19: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 197 Gazette royale — 15 février 2017

Mullen Trucking L.P. Alberta Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

620299 2017 01 24

Tenold Transportation Limited Partnership Alberta Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

620300 2017 01 24

Payne Transportation L.P. Alberta Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

620301 2017 01 24

GAS DRIVE GLOBAL LP Alberta Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

661631 2017 01 24

Travelodge (Canada) Limited Partnership Alberta Steven D. ChristieFredericton

662256 2017 01 23

FNA Fertilizer Limited Partnership Ontario Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

666230 2017 01 24

Loi sur les sociétés en commanditeLimited Partnership Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of withdrawal of extra-provincial limitedpartnership has been filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de retrait de société en commandite extraprovinciale aété déposée par :

ReferenceAgent and Address Number Date

Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence et adresse référence année mois jour

NOTICE OF INTENT TO APPLYFOR A TITLE DECLARATION

(FORM 70A)TO WHOM IT MAY CONCERNTAKE NOTICE THAT:Emery Gallant and Bernice Gallant of 2595 Route 530, Grande-Digue, New Brunswick, intend to apply for a title declaration inrelation to the land located on the north side of Route 530, hav-ing PID 25420266, at Grande-Digue, New Brunswick, as de-scribed in the attached Schedule “A”.

The title declaration sought is as follows:A full title declaration certifying Emery Gallant and BerniceGallant are the owners of the piece and parcel of land locatedon the north side of Route 530, having PID 25420266 andPAN 5919165 at Grande-Digue, Parish of Dundas, in theCounty of Kent and Province of New Brunswick, as de-scribed in the attached Schedule “A”.

The title declaration, if granted, will bind all persons.

Notices

AVIS D’INTENTION DE SOLLICITERUNE DÉCLARATION DE TITRE DE PROPRIÉTÉ

(FORMULE 70A)À QUI DE DROITSACHEZ QUE :Emery Gallant et Bernice Gallant, du 2595, Route 530 Grand-Digue, Nouveau-Brunswick, entendent solliciter une déclara-tion de propriété relativement au bien-fonds sis au nord de laRoute 530, dont le NID est 25420266 situé à Grande-Digue,Nouveau-Brunswick,tel qu’il est décrit dans l’annexe «A».

La déclaration de titre de propriété recherché est ainsi établie: Une déclaration complète de titre certifiant que Emery Gal-lant et Bernice Gallant sont les propriétaires du bien-fondssitué au nord de la Route 530, dont le NID est 25420266 etle numéro de compte du bien est 5919165, situé à Grande-Digue, comté de Kent, province du Nouveau-Brunswick, telqu’il est décrit dans l’annexe «A».

Si est accordée, la déclaration de titre de propriété liera toutesles personnes.

Avis

Page 20: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 198 Gazette royale — 15 février 2017

Si vous contestez ou mettez en question de quelque façon quece soit la déclaration de titre de propriété proposée, vous devez,au plus tard le 17e jour de mars, 2017, envoyer un contredit àl’adresse indiquée ci-après à la personne qui donne le présentavis et y énoncer les motifs de votre opposition. À cette fin,vous pouvez vous servir de la formule 70B des Règles de pro-cédure. En cas d’omission d’envoyer le contredit au plus tard àcette date, une instance pourra être introduite et une déclarationde titre de propriété pourra être accordée sur le fondement devotre absence d’opposition.FAIT à Moncton, N.-B., le 27e janvier, 2017.

RONALD J. LEBLANC, c.r.(Avocat d’Emery et Bernice Gallant)

LeBlanc Maillet735, rue Main, bureau 200, Moncton, NB E1C 1E5télé: 506-858-5666 téléc.: 506-858-5570courriel : [email protected]

ANNEXE « A »Toute la parcelle de terre située au nord de la route 530 et au suddu détroit de Northumberland, à Cap de Cocagne, paroisse deDundas, comté de Kent, province du Nouveau-Brunswick, etplus précisément délimitée et désignée comme suit :

Nota : Dans la désignation suivante, les azimuts et les distancesmentionnés sont ceux du système de coordonnées rectangu-laires du Nouveau-Brunswick NAD 83 (SCRS) et les coordon-nées mentionnées sont celles dudit système.PARTANT d'une borne d'arpentage correspondant au point100 sur le plan d'arpentage du bien-fonds d’Emery Gallantdressé par WSP Canada Inc., ledit plan ayant été établi le 14 mai2015 et signé par Howard S. McLaren, AGNB. La borne d'ar-pentage étant située du côté nord de ladite route 530, à l'inter-section de la limite est du bien-fonds appartenant ou ayant ap-partenu à Ozélie Cassie, NID 25093410. La borne d'arpentage,située sur ledit point de départ, ayant les coordonnéesN. 7 486 236,283 mètres et E. 2 650 418,819 mètres;DE LÀ, vers le nord, selon l'azimut 170o 16’ 50”, le long de la-dite limite est du bien-fonds appartenant ou ayant appartenu àOzélie Cassie, sur une distance d'environ 38,5 mètres jusqu'à unpoint situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires du détroit deNorthumberland;DE LÀ, vers l'est, le long des divers méandres de la ligne deshautes eaux ordinaires du détroit de Northumberland, sur unedistance d'environ 462 mètres jusqu'à un point;

DE LÀ, vers le sud, selon l'azimut 199o 53’ 9”, sur une distanced'environ 12,1 mètres jusqu'à une borne d'arpentage située ducôté nord de la route 530, ladite borne d'arpentage ayant lescoordonnées N. 7 486 027,442 mètres etE. 2 650 808,563 mètres;DE LÀ, vers l'ouest, selon l'azimut 298o 59’ 29”, le long ducôté nord de la route 530, sur une distance de 324,917 mètresjusqu'à un point;DE LÀ, vers le sud, selon l'azimut 208o 59’ 29”, sur une dis-tance de 5,182 mètres jusqu’à un point situé sur la route 530;DE LÀ, vers l'ouest, selon l'azimut 298o 59’ 29”, sur une dis-tance de 16,361 mètres jusqu’à un point situé sur la route 530;

If you dispute or question the proposed title declaration in anyway, you must, no later than the 17th day of March, 2017, senda dispute note to the person giving this notice at the addressgiven below. Form 70B of the Rules of Court may be used for adispute note. You must indicate the reasons for the objection inyour dispute note. If you fail to send a dispute note by that date,a proceeding may be commenced and a title declaration grantedon the basis that you do not oppose it.

DATED at Moncton, NB, this 27th day of January, 2017.

RONALD J. LEBLANC, Q.C.(Solicitor for Emery and Bernice Gallant)

LeBlanc Maillet735 Main Street, Suite 200, Moncton, NB, E1C 1E5Tel: 506-858-5666 Fax: 506-858-5570email: [email protected]

SCHEDULE “A”All that certain Lot, Piece or Parcel of land situated, lying andbeing north of Route 530 and South of the NorthumberlandStrait, Cap de Cocagne, Parish of Dundas, County of Kent,Province of New Brunswick, being more particularly boundedand described as follows:Note: In the following description, the azimuths and distancesare referred to the New Brunswick, NAD 83 (CSRS) plane co-ordinate grid system and the coordinate values stated are thoseof the said system.BEGINNING at a Survey Marker, being point #100 shown ona Plan of Survey of lands of Emery Gallant prepared by WSPCanada Inc., this plan being dated May 14, 2015 and signed byHoward S. McLaren N.B.L.S. The survey marker is situated onthe North side of the said Route 530, at the intersection of theEast boundary of the lands now or formerly belonging to OzelieCassie, PID 25093410. The Survey Marker at the said point ofcommencement having co-ordinate values of North7486236.283 metres and East 2650418.819 metres;THENCE, running Northerly on an Azimuth of 170–16’–50”along the said East boundary of the lands now or formerly be-longing to Ozelie Cassie a distance of approximately 38.5 me-tres to a point at the ordinary high water mark of the Northum-berland Strait;THENCE, running in an Easterly direction and following thevarious courses of the ordinary high water mark of the Nor-thumberland Strait a distance of approximately 462 metres to apoint;THENCE, running Southerly on an Azimuth of 1990–53’–09”a distance of approximately 12.1 meters to a Survey Marker atthe North side of Route 530. Said Survey Marker having co-or-dinate values of North 7486027.442 metres and East2650808.563 metres;THENCE, running Westerly on an Azimuth of 2980–59’–29”along the North side of Route 530, a distance of 324.917metersto a point;THENCE, running Southerly on an Azimuth of 2080–59’–29”a distance of 5.182 meters a point on Route 530;THENCE, running Westerly on an Azimuth of 2980–59’–29” adistance of 16.361 meters a point on Route 530;

Page 21: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 199 Gazette royale — 15 février 2017

DE LÀ, toujours vers l'ouest, selon l'azimut 298o 23’ 50”, surune distance de 100,854 mètres jusqu'au POINT DE DÉ-PART.La parcelle susdésignée devant correspondre à une bande deterre d’environ 8 300 mètres carrés correspondant à une partiedes biens-fonds cédés à Emery Gallant par l'acte de transfert en-registré au bureau de l'enregistrement du comté de Kent, sous lenuméro 113752, à la page 433 du registre V-9.

AVIS DE RÈGLEL’établissement des modifications apportent des modificationsà certaines normes canadiennes et multilatérales, à certainesrègles locales qui suivent :• Norme multilatérale 11-102 sur le régime de passeport;• Norme canadienne 14-101 sur les définitions;• Norme canadienne 21-101 sur le fonctionnement du marché;• Norme canadienne 23-102 sur l’emploi des courtages;

• Norme canadienne 31-103 sur les obligations et dispensesd’inscription et les obligations continues des personnes ins-crites;

• Instruction complémentaire 31-103IC sur les obligations etdispenses d’inscription et les obligations continues des per-sonnes inscrites;

• Norme canadienne 55-104 sur les exigences et dispenses dedéclaration d’initié;

• Au Nouveau-Brunswick, la Règle locale 31-502 sur les exi-gences supplémentaires applicables à l’inscription de laCommission des services financiers et des services auxconsommateurs du Nouveau-Brunswick.

(ensemble, les modifications).

Consentement ministérielLe 6 décembre 2017, la ministre des finances a donné sonconsentement à l’établissement des modifications énoncées ci-dessus.

Résumé des modificationsLe 13 décembre 2013, des modifications à la Loi sur les valeursmobilières (Nouveau-Brunswick) (la loi du N.-B.) ont été pro-mulguées afin de servir de cadre de réglementation en matièrede dérivés. Entre autres, la loi du N.-B. a été modifiée pour yajouter la définition de « dérivé » et pour remplacer partout dansla loi du N.-B. les expressions « contrat de change » et « contratà terme » par « dérivé », lorsque nécessaire. Leur mise en appli-cation permet de tenir compte de ces modifications législatives.

Date d’entrée en vigueurLes modifications sont entrées en vigueur au Nouveau-Brunswick le 1 février 2016.

Commission des services financiers et des services

aux consommateurs

THENCE, continuing Westerly on an Azimuth of 2980–23’–50” a distance of 100.854 meters to the PLACE OF BEGIN-NING;Being intended to described a tract of land containing 8300m2

more or less. Being a portion of those lands conveyed to EmeryGallant by deed registered in the Kent County Records as num-ber 113752, in volume V-9, page 433.

NOTICE OF RULEThe making of amendments to certain national, multilateral andlocal instruments as follows:

• Multilateral Instrument 11-102 Passport System;• National Instrument 14-101 Definitions;• National Instrument 21-101 Marketplace Operation;• National Instrument 23-102 Use of Client Brokerage Com-

missions;• National Instrument 31-103 Registration Requirements, Ex-

emptions and Ongoing Registrant Obligations;

• Companion Policy 31-103 Registration Requirements, Ex-emptions and Ongoing Registrant Obligations;

• National Instrument 55-104 Insider Reporting Requirementsand Exemptions; and in New Brunswick

• Financial and Consumer Services Commission (New Bruns-wick) Local Rule 31-502 Supplementary Registration Re-quirements.

(Together, the Amendments).

Ministerial ConsentOn 6 December, 2016, the Minister of Finance consented to themaking of the above-noted amendments.

Summary of AmendmentsOn December 13, 2013, amendments to the Securities Act (NewBrunswick) (the NB Act) were proclaimed to create a frame-work for derivatives regulation. Among other things, the NBAct was amended to add a definition of “derivative” and to re-place throughout the NB Act, where necessary, the terms “ex-change contract” and “futures contract” with the term “deriva-tive”. The Amendments are being implemented to reflect thisamended legislation.

Effective DateThe amendments came into force in New Brunswick on 1 Feb-ruary 2017.

Financial and Consumer Services Commission

Page 22: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 200 Gazette royale — 15 février 2017

Comment obtenir un exemplaireOn trouvera le texte des modifications énoncées ci-dessus parl’entremise du site web de la Commission : http://www.fcnb.ca

On peut se procurer un exemplaire sur papier du document encommuniquant par courrier, par téléphone ou par courriel avecla Commission, dont voici les coordonnées:

SecrétaireCommission des services financiers etdes services aux consommateurs85, rue Charlotte, bureau 300Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2Téléphone : 506-658-3060Sans frais : 1-866-933-2222 (au N.-B. seulement)Télécopieur : 506-658-3059 Courriel : [email protected]

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, ch. S-2, para. 1(2)

Destinataires : Daniel Paul Jalbert et Marise Robichaud Jalbert,débiteurs hypothécaires originaires et propriétaires du droit derachat; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertudes dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi surles biens, L.R.N.-B. 1973, ch. P-19. Biens en tenure libre situésau 46, avenue Ordonnance, à Edmundston, comté de Ma-dawaska, province du Nouveau-Brunswick, et dont le NIDest 35128966.Avis de vente donné par la Banque Toronto-Dominion, créan-cière hypothécaire et titulaire de la première hypothèque. Lavente aura lieu le mercredi 22 février 2017, à 11 h, heure locale,dans l’entrée principale du palais de justice d’Edmundston, auCarrefour Assomption, 121, rue de l’Église, Edmundston (Nou-veau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions du28 janvier et des 4, 11 et 18 février 2017 du journal Le Ma-dawaska.

R. Scott Wilson, du cabinet McInnes Cooper, avocats de laBanque Toronto-Dominion, Brunswick Square, 1, rue Germain,bureau 1700, C.P. 6370, Saint John (Nouveau-Brunswick)E2L 4R8; téléphone : 506-643-6500; télécopieur : 506-643-6505

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, ch. S-2, art. 1(2)

Destinataires : Marco Michel Guerrette et Melissa MichellePlourde, débiteurs hypothécaires et propriétaires du droit de ra-chat, et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée conformé-ment aux dispositions de l’acte d’hypothèque et de la Loi sur lesbiens, L.R.N.-B. 1973, ch. P-19. Biens en tenure libre situés au11528 Route 144, Saint-Léonard-Parent, province du Nouveau-Brunswick, lesdits biens correspondant au même lot ayant été

Avis de vente

How to Obtain a CopyThe text of the above-noted amendments can be obtained fromthe Commission’s website: http://www.fcnb.ca

Paper copies may be obtained from the Commission by writing,telephoning or e-mailing:

SecretaryFinancial and ConsumerServices Commission85 Charlotte Street, Suite 300Saint John, N.B. E2L 2J2Telephone: 506-658-3060Toll Free: 866-933-2222 (within NB only)Fax: 506-658-3059 E-mail: [email protected]

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Daniel Paul Jalbert and Marise Robichaud Jalbert, originalmortgagors and owners of the equity of redemption; and to: allothers whom it may concern. Sale pursuant to the terms of themortgage and the Property Act, R.S.N.B. 1973, c.P-19, asamended. Freehold property situate at 46 Ordonnance Avenue,Edmundston, in the County of Madawaska and Province ofNew Brunswick, and being identified as PID 35128966.

Notice of Sale given by The Toronto-Dominion Bank, mort-gagee and holder of the first mortgage. Sale to be held at thefront lobby of the Edmundston Court House, Offices of Carre-four Assomption, 121 rue de l’Eglise/Church Street, Ed-mundston, New Brunswick on Wednesday, February 22, 2017,at the hour of 11:00 a.m., local time. See advertisement of No-tice of Mortgage Sale in le Madawaska dated January 28, Feb-ruary 4, 11 and 18, 2017.

McInnes Cooper, Solicitors for The Toronto-Dominion Bank,Per: R. Scott Wilson, Suite 1700, Brunswick Square, 1 GermainStreet, P.O. Box 6370, Saint John, New Brunswick, E2L 4R8.Telephone: 506-643-6500. Facsimile: 506-643-6505.

________________

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Marco Michel Guerrette and Melissa Michelle Plourde,mortgagors and owners of the equity of redemption, and all oth-ers whom it may concern. Sale under the terms of the mortgageand the Property Act, R.S.N.B. 1973, c.P-19. Freehold propertysituate at 11528 Route 144, in Saint-Léonard-Parent, Provinceof New Brunswick, the said land corresponding to the same lothaving been conveyed to Marco Michel Guerrette and Melissa

Notices of Sale

Page 23: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 201 Gazette royale — 15 février 2017

Michelle Plourde by deed registered at the Registry Office asNumber 31890172.

Notice of sale given by the Bank of Nova Scotia, mortgagee.Sale on March 2, 2017, at 11:00 a.m., local time, at CarrefourAssomption, 121 De l’Église Street, Edmundston, New Bruns-wick. See notice of sale in the February 2, 9, 16, and 23, 2017,editions of L’Étoile République.

McInnes Cooper, Solicitors for the Bank of Nova Scotia, perAdel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400,P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick E1C 8T6, telephone:506-857-8970, fax: 506-857-4095

________________

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s. 1(2)

To: Evan Patrick Parlee and Rachel Charlene Parlee, originalMortgagors; and to: all others whom it may concern. Sale pur-suant to terms of the Mortgage and the Property Act R.S.N.B.,1973, c.P-19 and Acts in amendment thereof. Freehold propertybeing situated at 110 McFarlane Road, Waterford, New Bruns-wick, the same lot conveyed to Evan Patrick Parlee and RachelCharlene Parlee by Transfer registered in the Land Titles Officeon August 15, 2014, as document number 34070434.

Notice of Sale given by Bank of Montreal. Sale to be held atSaint John Court House, located at 10 Peel Plaza, Saint John,New Brunswick, on the 23rd day of February, 2017, at the hourof 11:00 a.m., local time. See advertisement of Notice of Sale inthe Telegraph-Journal dated January 26, February 2, 9 and 16,2, 2017.

McInnes Cooper, Solicitors for Bank of Montreal, Per: AdelGönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400, P.O.Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6. Telephone:506-857-8970. Facsimile: 506-857-4095.

________________

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To the Estate of Thomas Paul Thompson, original Mortgagor,and to: all others whom it may concern. Sale pursuant to termsof the Mortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19and Acts in amendment thereof. Freehold property being situ-ated at 6721 Route 117, Bay du Vin, New Brunswick, the samelot conveyed to Thomas Paul Thompson by Deed registered inthe Land Titles Office on September 4, 2007, as number24436702.Notice of Sale given by Scotia Mortgage Corporation. Sale tobe held at Service New Brunswick offices, located at 360 Pleas-ant Street, Miramichi, New Brunswick, on the 1st day of March,2017, at the hour of 11:00 a.m., local time. See advertisement of

transféré à Marco Michel Guerrette et Melissa Michelle Plourdepar Transfert enregistré au bureau d’enregistrement fonciersous le numéro 31890172.Avis de vente donné par la Banque de Nouvelle-Écosse, créancièrehypothécaire. La vente aura lieu le 2 mars 2017 à 11h00, heure lo-cale, au Carrefour Assomption, 121 rue de l’Église, Edmundston(Nouveau-Brunswick). Voir l’avis de vente publié dans les éditionsL’Étoile République du 2, 9, 16 et 23 février 2017.

McInnes Cooper, avocats de la Banque de Nouvelle-Écosse,par Adel Gönczi, Centre Croix Bleue, 644, rue Main, PièceS400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6,téléphone : 506-857-8970, télécopieur : 506-857-4095

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, ch. S-2, para. 1(2)

Destinataires : Evan Patrick Parlee et Rachel Charlene Parlee,débiteurs hypothécaires originaux; et tout autre intéressé éven-tuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypo-thèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B 1973,ch. P-19. Biens en tenure libre situés au 110, chemin McFar-lane, à Waterford, au Nouveau-Brunswick, et correspondant aumême lot ayant été transféré à Evan Patrick Parlee etRachel Charlene Parlee par l’acte de transfert enregistré au bu-reau d’enregistrement foncier le 15 août 2014, sous le nu-méro 34070434.Avis de vente donné par la Banque de Montréal. La vente auralieu le 23 février 2017, à 11 h, heure locale, au palais de justicede Saint John, 10, place Peel, Saint John (Nouveau-Brunswick).Voir l’annonce publiée dans les éditions du 26 janvier et des 2,9 et 16 février 2017 du Telegraph-Journal.

Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banquede Montréal, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Main, bu-reau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6;téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, ch. S-2, para. 1(2)

Destinataires : La succession de Thomas Paul Thompson, débi-teur hypothécaire originaire; et tout autre intéressé éventuel.Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypo-thèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B 1973,ch. P-19. Biens en tenure libre situés au 6721, route 117, à Baydu Vin, au Nouveau-Brunswick, et correspondant au même lotayant été transféré à Thomas Paul Thompson par l’acte detransfert enregistré au bureau d’enregistrement foncier le 4 sep-tembre 2007, sous le numéro 24436702.Avis de vente donné par la Société hypothécaire Scotia. Lavente aura lieu le 1er mars 2014, à 11 h, heure locale, au centrede Service Nouveau-Brunswick, 360, rue Pleasant, Miramichi

Page 24: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 202 Gazette royale — 15 février 2017

Notice of Sale in The Miramichi Leader dated February 1, 8, 15and February 22, 2017.

McInnes Cooper, Solicitors for Scotia Mortgage Corporation,Per: Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, SuiteS400, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6.Telephone: (506) 857-8970. Facsimile: (506) 857-4095.

________________

BERTIN JR BERNIER and ROLANDE BERNIER, ownersof the land having the civic address of 129 34th Avenue, inEdmundston, in the County of Madawaska and Province ofNew Brunswick, mortgagors, the CAISSE POPULAIREACADIENNE LTÉE (formerly the Caisse populaireMadawaska Ltée), first mortgagee, and to ALL OTHERSWHOM IT MAY CONCERN.

Land having the civic address of 129 34th Avenue, inEdmundston, in the County of Madawaska and Province ofNew Brunswick, and bearing PID 35125582.Notice of sale given by the above holder of the first mortgage.

Sale on March 8, 2017, at 11:00 a.m., at Carrefour Assomption,121 De l’Église Street, in Edmundston, New Brunswick. Seeadvertisement in the February 11, 18, 25, and March 4, 2017,editions of the weekly Le Madawaska.DATED at Edmundston, New Brunswick, this 1st day of Feb-ruary, 2017.

Gary J. McLaughlin, Q.C., Mclaughlin Law Offices, Solicitorsand agents for the Caisse populaire acadienne Ltée (formerlythe Caisse populaire Madawaska Ltée)

The Royal Gazette is published every Wednesday under theauthority of the Queen’s Printer Act. Documents must be re-ceived by the Royal Gazette coordinator, Legislative Services,no later than noon, at least seven days prior to Wednesday’spublication. Each document must be separate from the cover-ing letter. Signatures on documents must be immediately fol-lowed by the printed name. The Royal Gazette coordinatormay refuse to publish a document if any part of it is illegible,and may delay publication of any document for administrativereasons.Prepayment is required for the publication of all documents.Standard documents have the following set fees:

NoticesCost perInsertion

Notice of the intention to apply for the enactment of a private bill

$ 20

Originating process $ 25Order of a court $ 25Notice under the Absconding Debtors Act $ 20

Notice to Advertisers

(Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditionsdes 1er, 8, 15 et 22 février 2017 du Miramichi Leader.

Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Sociétéhypothécaire Scotia, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Main, bu-reau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6;téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

________________

BERTIN JR BERNIER et ROLANDE BERNIER, proprié-taires du bien-fonds ayant l’adresse civique 129, 34e Avenue, àEdmundston, dans le comté de Madawaska et province du Nou-veau-Brunswick, à titre de débiteurs hypothécaires, CAISSEPOPULAIRE ACADIENNE LTÉE (autrefois connue sousle nom de Caisse populaire Madawaska Ltée), à titre decréancière hypothécaire d’une hypothèque de premier rang et ÀTOUS AUTRES INTÉRESSÉS ÉVENTUELSBien-fonds ayant l’adresse civique 129, 34e Avenue, àEdmundston, dans le comté de Madawaska et province duNouveau-Brunswick et connue sous le NID 35125582.Avis de vente donné par le titulaire susnommé de la premièreHypothèque.Vente le 8 mars 2017 à 11h00 a.m. au Carrefour Assomption,121, rue de l’Église, Edmundston, N.-B. Voir l’annonce paruedans le journal hebdomadaire Le Madawaska, éditions des 11,18, 25 février et 4 mars 2017.FAIT à Edmundston, Nouveau-Brunswick, le 1er jour de fé-vrier 2017.

Gary J. McLaughlin, c.r., Cabinet Juridique McLaughlin,Avocats et agents pour Caisse populaire acadienne Ltée (autre-fois connue sous le nom de Caisse populaire Madawaska Ltée)

La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformé-ment à la Loi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents àpublier doivent parvenir au coordonnateur de la Gazetteroyale, aux Services législatifs, à midi, au moins sept joursavant le mercredi de publication. Chaque avis doit être séparéde la lettre d’envoi. Les noms des signataires doivent suivreimmédiatement la signature. Le coordonnateur de la Gazetteroyale peut refuser de publier un avis dont une partie est illi-sible et retarder la publication d’un avis pour des raisons ad-ministratives.Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis.Voici les tarifs pour les avis courants :

AvisCoût par parution

Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loid’intérêt privé

20 $

Acte introductif d’instance 25 $Ordonnance rendue par une cour 25 $Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite 20 $

Avis aux annonceurs

Page 25: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 203 Gazette royale — 15 février 2017

Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque ormoney order (payable to the Minister of Finance). No refundswill be issued for cancellations.

The official version of The Royal Gazette is available freeon-line each Wednesday. This free on-line service replaces theprinted annual subscription service. The Royal Gazette can beaccessed on-line at:

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/attorney_general/royal_gazette.html

Print-on-demand copies of The Royal Gazette are available, atthe following address, at $4.00 per copy plus 5% tax, plusshipping and handling where applicable.

Notice: The telephone number for The Royal Gazette haschanged. Please see below.

Legislative PublishingOffice of the Attorney General

Chancery Place675 King StreetP.O. Box 6000

Fredericton, NB E3B 5H1

Tel: 506-453-2520E-mail: [email protected]

Notice under the General Rules under the Law Society Act,1996, of disbarment or suspension or of application forreinstatement or readmission

$ 20

Notice of examination under the Licensed Practical NursesAct

$ 25

Notice under the Motor Carrier Act $ 30Any document under the Political Process Financing Act $ 20

Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9under the Probate Court Act

$ 20

Notice under Rule 70 of the Rules of CourtNote: Survey Maps cannot exceed 8.5″ x 14″

$120

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is1/2 page in length or less

$ 20

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice isgreater than 1/2 page in length

$ 75

Any document under the Winding-up and Restructuring Act(Canada)

$ 20

Notice of a correction charge isthe same as

for publishing the original document

Any other document $3.50 for each cm or less

Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte decrédit MasterCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (àl’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement nesera effectué en cas d’annulation.

La version officielle de la Gazette royale est disponible gra-tuitement en ligne chaque mercredi. Ce service gratuit enligne remplace le service d’abonnement annuel. Vous trouve-rez la Gazette royale à l’adresse suivante :

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/procureur_general/gazette_royale.html

Nous offrons sur demande des exemplaires de la Gazetteroyale à l’adresse suivante pour la somme de 4 $ l’exemplaire,plus la taxe de 5 % ainsi que les frais applicables de port et demanutention.

Avis : Le numéro de téléphone de la Gazette royale a changé.Prière de voir ci-dessous.

Publications législativesCabinet du procureur général

Place-Chancery675, rue King

C.P. 6000Fredericton (N.-B.) E3B 5H1

Tél. : 506-453-2520Courriel : [email protected]

Avis de radiation ou de suspension ou de demande deréintégration ou de réadmission, exigé par les Règlesgénérales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur leBarreau

20 $

Avis d’examen exigé par la Loi sur les infirmières etinfirmiers auxiliaires autorisés

25 $

Avis exigé par la Loi sur les transports routiers 30 $Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur le

financement de l’activité politique20 $

Avis aux créanciers exigé par le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour dessuccessions

20 $

Avis exigé par la Règle 70 des Règles de procédureNota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 po

sur 14 po

120 $

Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est d’une demi-page ou moins enlongueur

20 $

Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est de plus d’une demi-page enlongueur

75 $

Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur lesliquidations et les restructurations (Canada)

20 $

Avis d’une correction les frais sont les mêmes que ceux imposés

pour la publication du

document original

Tout autre document 3,50 $ pour chaque cm ou

moins

Page 26: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 204 Gazette royale — 15 février 2017

Note: Deliveries are to be addressed to The Royal Gazette andleft with the commissionaire.

Statutory Orders and Regulations Part II

Note : Toute livraison étant adressée à la Gazette royale doitêtre remise au commissionnaire.

Ordonnances statutaires et Règlements Partie II

Page 27: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 205 Gazette royale — 15 février 2017

NEW BRUNSWICKREGULATION 2017-1

under the

RÈGLEMENT DUNOUVEAU-BRUNSWICK 2017-1

pris en vertu de la

FISH AND WILDLIFE ACT(O.C. 2017-10)

LOI SUR LE POISSON ET LA FAUNE(D.C. 2017-10)

Filed January 27, 2017 Déposé le 27 janvier 2017

1 Section 3 of New Brunswick Regulation 2015-4 un-der the Fish and Wildlife Act is amended

1 L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick2015-4 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la fauneest modifié

(a) in paragraph (bb) by striking out the period atthe end of the paragraph and substituting a semico-lon;

a) à l’alinéa bb), par la suppression du point à lafin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;

(b) by adding after paragraph (bb) the following: b) par l’adjonction de ce qui suit après l’ali-néa bb) :

(cc) a varmint licence referred to in paragraph3(1)(f) or (g) of New Brunswick Regulation 84-133under the Act;

cc) le permis de chasse aux nuisibles visé à l’ali-néa 3(1)f) ou g) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-133 pris en vertu de la Loi;

(dd) a resident bear licence referred to in paragraph3(1)(i) of New Brunswick Regulation 84-133 underthe Act.

dd) le permis de chasse à l’ours pour résident visé àl’alinéa 3(1)i) du Règlement du Nouveau-Brunswick84-133 pris en vertu de la Loi.

2 This Regulation comes into force on February 1,2017.

2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er fé-vrier 2017.

Page 28: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 206 Gazette royale — 15 février 2017

NEW BRUNSWICKREGULATION 2017-2

under the

RÈGLEMENT DUNOUVEAU-BRUNSWICK 2017-2

pris en vertu de la

FISH AND WILDLIFE ACT(O.C. 2017-11)

LOI SUR LE POISSON ET LA FAUNE(D.C. 2017-11)

Filed January 27, 2017 Déposé le 27 janvier 2017

1 Section 3.001 of the New Brunswick Regulation84-133 under the Fish and Wildlife Act is amended bystriking out “paragraph 3(1)(a), (b), (c), (d) or (e)” andsubstituting “paragraph 3(1)(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g)or (i)”.

1 L’article 3.001 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-133 pris en vertu de la Loi sur le poissonet la faune est modifié par la suppression de « l’ali-néa 3(1)a), b), c), d) ou e) » et son remplacement par« l’alinéa 3(1)a), b), c), d), e), f), g) ou i) ».

2 The Regulation is amended by adding after section21.1 the following:

2 Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce quisuit après l’article 21.1 :

21.11(1) For the purposes of this Regulation, a tag isassociated with a resident bear licence if the tag has beenactivated under subsection (3) in respect of that licence.

21.11(1) Pour l’application du présent règlement, uneétiquette est en lien avec un permis de chasse à l’ourspour résident si elle a été activée en vertu du paragra-phe (3) par rapport à ce permis.

21.11(2) At the same time as he or she applies for thelicence, an applicant for a resident bear licence shall ap-ply for the activation of a tag in respect of the licence.

21.11(2) Le demandeur du permis de chasse à l’ourspour résident doit, tout en présentant sa demande de per-mis, demander que soit activée une étiquette par rapportà ce permis.

21.11(3) On an application under subsection (2), theMinister may activate a tag in respect of a resident bearlicence using the unique alphanumeric identifier printedon the tag.

21.11(3) Sur demande présentée en vertu du paragra-phe (2), le Ministre peut activer une étiquette par rapportà un permis de chasse à l’ours pour résident au moyen del’identificateur alphanumérique unique imprimé sur l’éti-quette.

21.11(4) A tag associated with a resident bear licenceis not valid if it does not comply with Schedule A.

21.11(4) Est frappée d’invalidité l’étiquette en lienavec un permis de chasse à l’ours non conforme à l’an-nexe A.

21.11(5) No person shall hunt bear under a residentbear licence once the tag associated with the licence hasbeen used.

21.11(5) Nul ne peut chasser l’ours en vertu d’un per-mis de chasse à l’ours pour résident une fois qu’a été uti-lisée l’étiquette en lien avec le permis.

Page 29: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 207 Gazette royale — 15 février 2017

21.11(6) The holder of a resident bear licence whokills a bear shall immediately affix the tag associatedwith his or her licence to the bear in accordance withSchedule B.

21.11(6) Le titulaire d’un permis de chasse à l’ourspour résident qui tue un ours fixe immédiatement à ladépouille l’étiquette en lien avec son permis conformé-ment à l’annexe B.

21.11(7) The tag shall remain attached until the bearhas been presented for registration.

21.11(7) L’étiquette reste en place jusqu’à l’enregis-trement de l’ours.

3 Section 21.2 of the Regulation is amended 3 L’article 21.2 du Règlement est modifié

(a) in paragraph (1)(a) by striking out “residentbear licence and”;

a) à l’alinéa (1)a), par la suppression de « pour ré-sident et »;

(b) in subsection (1.1) by striking out “a residentbear licence or”;

b) au paragraphe (1.1), par la suppression de« pour résident ou »;

(c) in subsection (2) by striking out “Every personhaving killed a bear shall immediately detach the tagfrom his or her licence” and substituting “Theholder of a non-resident bear licence who kills a bearshall immediately detach the tag from his or her li-cence”.

c) au paragraphe (2), par la suppression de « Qui-conque tue un ours doit immédiatement détacherl’étiquette de son permis et apposer l’étiquette » etson remplacement par « Le titulaire d’un permis dechasse à l’ours pour non-résident qui tue un ours déta-che immédiatement l’étiquette de son permis et l’ap-pose ».

4 Subsection 21.3(3) of the Regulation is amended 4 Le paragraphe 21.3(3) du Règlement est modifié

(a) by repealing paragraph (a) and substituting thefollowing:

a) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplace-ment par ce qui suit :

(a) affix or allow to be affixed to a bear a tag asso-ciated with a resident bear licence other than the resi-dent bear licence of the person who killed the bear,

a) étiqueter un ours ou permettre son étiquetage aumoyen d’une étiquette en lien avec un permis dechasse à l’ours pour résident autre que celui dont esttitulaire la personne qui a tué l’ours,

(b) by adding after paragraph (a) the following: b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :

(a.1) affix or allow to be affixed to a bear a tag froma non-resident bear licence other than the non-residentbear licence of the person who killed the bear,

a.1) étiqueter un ours ou permettre son étiquetageau moyen d’une étiquette provenant d’un permis dechasse à l’ours pour non-résident autre que celui dontest titulaire la personne qui a tué l’ours,

5 Schedule A of the Regulation is repealed and theattached Schedule A is substituted.

5 L’annexe A du Règlement est abrogée et remplacéepar l’annexe A ci-jointe.

6 Schedule B of the Regulation is repealed and theattached Schedule B is substituted.

6 L’annexe B du Règlement est abrogée et remplacéepar l’annexe B ci-jointe.

7 This Regulation comes into force on February 1,2017.

7 Le présent règlement entre en vigueur le 1er fé-vrier 2017.

Page 30: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 208 Gazette royale — 15 février 2017

SCHEDULE A ANNEXE ATAG – CLASS I OR CLASS III LICENCE

OR RESIDENT BEAR LICENCEÉTIQUETTE EN LIEN AVEC LE PERMIS DE

CATÉGORIE I OU DE CATÉGORIE IIIOU LE PERMIS DE CHASSE À L’OURS

POUR RÉSIDENT1 Description 1 Description

A tag associated with a class I or class III licence or aresident bear licence has two parts: a sticker and a metalwire as illustrated below. The Province of New Bruns-wick galley logo shall be printed on the sticker in the up-per right-hand corner. The tag shall be blue in colour andbear a unique alphanumeric identifier assigned by theMinister. The tag shall bear blank spaces on which ahunter may check off the species and record the year andthe hunter’s first and last name.

L’étiquette en lien avec le permis de catégorie I ou decatégorie III ou avec le permis de chasse à l’ours pourrésident est formée de deux éléments : un autocollant etune attache métallique, comme le montre l’illustrationci-dessous. Le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick est imprimé sur l’autocollant, dans le coin su-périeur droit. L’étiquette est bleue et porte unidentificateur alphanumérique unique qu’attribue le Mi-nistre. Elle comporte des espaces en blanc qui permettentau chasseur d’indiquer l’espèce abattue, l’année ainsique ses nom et prénom.

2 Illustration 2 Illustration

Page 31: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 209 Gazette royale — 15 février 2017

Page 32: The Royal Gazette / Gazette royale (17/02/15) · The Royal Gazette — February 15, 2017 180 Gazette royale — 15 février 2017 JANUARY 18, 2017 2017-14 Under subparagraph 6(2)(b)(iii)

The Royal Gazette — February 15, 2017 210 Gazette royale — 15 février 2017

SCHEDULE B ANNEXE BFor the purposes of this Regulation, a tag associated witha class I or class III licence or a resident bear licenceshall be affixed to a deer or bear, as the case may be, by

Pour l’application du présent règlement, l’étiquette enlien avec le permis de catégorie I ou de catégorie III ouavec le permis de chasse à l’ours pour résident est fixéeau chevreuil ou à l’ours, selon le cas, selon les directivessuivantes :

a) inserting the metal wire through the skin of theright foreleg of the deer or bear;

a) insérer l’attache métallique à travers la peau de lapatte antérieure droite du chevreuil ou de l’ours;

b) peeling back the liner of the sticker and placing thewire on half of the sticky side of the sticker; and

b) détacher la pellicule protectrice de l’autocollant etplacer l’attache métallique sur la moitié du côté adhé-sif de l’autocollant;

c) folding the sticker over the ends of the metal wireand applying pressure.

c) replier l’autocollant sur les bouts de l’attache mé-tallique et appliquer de la pression.

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

All rights reserved/Tous droits réservés